Actos BORME de Agrupaejido Sa
12 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1619 , F 176, S 8, H AL 2435, I/A106 ( 5.06.23).
16 de Mayo de 2023Modificaciones estatutarias. 8BIS. Prenda sobre acciones y limitaciones a la libre transmisión de las acciones en los supuestos deejecución de derecho real de prenda. En caso de prenda de acciones de la Sociedad, el ejercicio de los derechos del sociocorresponderá al propietario de las mismas. No obstante lo anterior, el. Datos registrales. T 1619 , F 176, S 8, H AL 2435, I/A 105 (5.05.23).
21 de Marzo de 2023Situación concursal. Procedimiento concursal 682/2015. FIRME: Si, Fecha de resolución 21/02/2023. Auto de conclusión delconcurso. Cumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALMERIA. Juez: MARIA DELOS ANGELES BOSSINI RUIZ. Situación concursal. Procedimiento concursal 682/2015. Fecha de resolución 8/09/2015.Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL ALMERIA. Juez: MARIA LUISA DELGADOUTRERA/ MARIA ANGELES BOSSINI RUIZ. Administrador Concursal. Fecha 21/02/2023, NIF/CIF B65697740. LEXAUDITCONCURSAL SLP. Datos registrales. T 1619 , F 176, S 8, H AL 2435, I/A 104 ( 8.03.23).
06 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: MARTIN CASTELLANO R. A AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1619 , F 175, S 8, H AL 2435, I/A 101(27.01.23).
Reelecciones. Auditor: MARTIN CASTELLANO R. A AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1619 , F 175, S 8, H AL 2435, I/A 102(27.01.23).
Reelecciones. Auditor: MARTIN CASTELLANO R. A AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1619 , F 176, S 8, H AL 2435, I/A 103(27.01.23).
09 de Marzo de 2020Reelecciones. Auditor: MARTIN CASTELLANO R. A AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1619 , F 175, S 8, H AL 2435, I/A 100(26.02.20).
01 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: MARTIN CASTELLANO R. A AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1619 , F 175, S 8, H AL 2435, I/A 99(19.07.19).
20 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GUILLEN JIMENEZ CECILIO;GUILLEN LOPEZ DOLORES;JUAREZ NOGUEROL FRANCISCOJOSE. Presidente: GUILLEN JIMENEZ CECILIO. Cons.Del.Sol: GUILLEN JIMENEZ CECILIO. Secretario: GUILLEN LOPEZDOLORES. Cons.Del.Sol: JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Consejero: GUILLEN JIMENEZCECILIO;JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE;GUILLEN LOPEZ DOLORES. Presidente: GUILLEN JIMENEZ CECILIO.Secretario: GUILLEN LOPEZ DOLORES. Cons.Del.Sol: GUILLEN JIMENEZ CECILIO;JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE.Datos registrales. T 1619 , F 174, S 8, H AL 2435, I/A 98 (12.06.19).
05 de Febrero de 2019Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: MARTIN CASTELLANO R. AAUDITORES SLP. Datos registrales. T 1619 , F 173, S 8, H AL 2435, I/A 97 (23.01.19).
01 de Febrero de 2016Situación concursal. Procedimiento concursal 682/2015. Fecha de resolución 8/09/2015. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 1 DE LO MERCANTIL ALMERIA. Juez: MARIA LUISA DELGADO UTRERA/ MARIA ANGELES BOSSINI RUIZ.Administrador Concursal. Fecha 8/09/2015, NIF/CIF B65697740. LEXAUDIT CONCURSAL SLP. Situación concursal.
14 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apoderado: CERDAN NAVARRO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1619 , F 172, S 8, H AL 2435, I/A 94 (2.09.15).
Revocaciones. Apoderado: CAÑADAS SANCHEZ ANGEL FRANCISCO. Datos registrales. T 1619 , F 172, S 8, H AL 2435, I/A 95 (2.09.15).
11 de Agosto de 2015Nombramientos. Apoderado: GUILLEN RODRIGUEZ ALEX. Datos registrales. T 1619 , F 172, S 8, H AL 2435, I/A 93 ( 3.08.15).
14 de Abril de 2015Revocaciones. Apoderado: GARCIA FUENTES JOSE. Datos registrales. T 1619 , F 171, S 8, H AL 2435, I/A 91 ( 6.04.15).
17 de Junio de 2014Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1619 , F 171, S 8, H AL 2435, I/A90 ( 6.06.14).
16 de Abril de 2014Reelecciones. Consejero: GUILLEN JIMENEZ CECILIO. Presidente: GUILLEN JIMENEZ CECILIO. Consejero: GUILLEN LOPEZDOLORES. Secretario: GUILLEN LOPEZ DOLORES. Consejero: JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE. Cons.Del.Sol: GUILLENJIMENEZ CECILIO;JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 625 , F 225, S 8, H AL 2435, I/A 89 ( 8.04.14).
05 de Marzo de 2014Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 625 , F 225, S 8, H AL 2435, I/A88 (26.02.14).
03 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GUILLEN ROBLES ANTONIO JOSE. Vicesecret.: GUILLEN LOPEZ DOLORES. Revocaciones.Apoderado: GUILLEN ROBLES ANTONIO JOSE. Nombramientos. Secretario: GUILLEN LOPEZ DOLORES. Otros conceptos:Revocados los poderes no inscritos en favor de Don Antonio José Guillén Robles en escrituras otorgadas el 27-02-2013, ante elNotario de Almería, Sr. Sánchez de León, nº 586 y el 14-03-.2013, en El Ejido, ante el Notario Sr. Gutiérrez Delgado, nº 280. Datosregistrales. T 625 , F 225, S 8, H AL 2435, I/A 87 (26.08.13).
04 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MARTIN FRANCISCO ESTEBAN. Datos registrales. T 625 , F 225, S 8, H AL 2435, I/A 84(22.11.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ AMAT ANDRES;GUILLEN JIMENEZ JOSE. Cons.Del.Sol: GUILLEN RODRIGUEZ ALEX.Secretario: GUILLEN ROBLES ANTONIO JOSE. Vicepresid.: GUILLEN JIMENEZ MIGUEL. Nombramientos. SecreNoConsj:GUILLEN ROBLES ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 625 , F 225, S 8, H AL 2435, I/A 85 (22.11.12).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA LORENZO RICARDO. Datos registrales. T 625 , F 225, S 8, H AL 2435, I/A 86 (22.11.12).
22 de Junio de 2012Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Fe de erratas: Rectificada la inscripción 79& enel sentido de hacer constar que el nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad a "Pricewaterhousecoopers Auditores, sl", estambién para las cuentas anuales consolidadas del grupo, ejercicios 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012. Datos registrales. T 625 , F224, S 8, H AL 2435, I/A 83 ( 7.06.12).
28 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: GARCIA FUENTES JOSE;GARCIA FUENTES JOSE;GARCIA FUENTES JOSE. Otros conceptos:Revocado el poder, no inscrito, a favor de Don José García Fuentes, en virtud de escritura otorgada el día 19 de enero de 1999 anteDon Alfonso Rodriguez García, número 106 de protocolo. Datos registrales. T 625 , F 224, S 8, H AL 2435, I/A 81 (18.10.11).
Nombramientos. Apoderado: CERDAN NAVARRO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 625 , F 224, S 8, H AL 2435, I/A 82(19.10.11).
26 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LUNA LOPEZ RAFAEL. Datos registrales. T 625 , F 224, S 8, H AL 2435, I/A 80 (13.07.11).
20 de Octubre de 2010Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 625 , F 224, S 8, H AL 2435, I/A
30 de Agosto de 2010Ampliación de capital. Suscrito: 2.100.000,00 Euros. Desembolsado: 2.100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.700.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.700.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 5º.- El capital delasociedad es de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS, y estárepresentado por DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTAacciones alportador, de valor nominal DOS MIL EUROS, cada una de ellas, numeradas correltivamente del UNO AL DOS MILOCHOCIENTOS. Datos registrales. T 625 , F 223, S 8, H AL 2435, I/A 78 (18.08.10).
15 de Junio de 2010Revocaciones. Apoderado: PEÑIN CACHON AGUSTIN. Datos registrales. T 625 , F 223, S 8, H AL 2435, I/A 77 ( 3.06.10).
27 de Abril de 2010Revocaciones. Apoderado: FUENTES CARA ANGEL MANUEL. Datos registrales. T 625 , F 223, S 8, H AL 2435, I/A 75 ( 9.04.10).
Revocaciones. Apo.Sol.: GUILLEN LOPEZ DOLORES;GONZALEZ FERRE JOSE LUIS;GARCIA RUEDA JOSE;CEREZUELAALMENDROS JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 625 , F 223, S 8, H AL 2435, I/A 76 ( 9.04.10).
31 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: LUNA LOPEZ RAFAEL. Datos registrales. T 625 , F 222, S 8, H AL 2435, I/A 71 (19.03.10).
Revocaciones. Apoderado: MATEO MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 625 , F 223, S 8, H AL 2435, I/A 72 (19.03.10).
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ RODRIGUEZ VICTORIANO. Datos registrales. T 625 , F 223, S 8, H AL 2435, I/A 73(19.03.10).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUNA LOPEZ RAFAEL;GARCIA MARTIN FRANCISCO ESTEBAN;LOPEZ AMATANDRES;SANTANA ALEMAN JUAN. Secretario: SANTANA ALEMAN JUAN. Cons.Del.Sol: SANTANA ALEMAN JUAN. Consejero:GUILLEN ROBLES ANTONIO JOSE. Vicesecret.: GUILLEN ROBLES ANTONIO JOSE. Consejero: GUILLEN JIMENEZ MIGUEL.Vicepresid.: GUILLEN JIMENEZ MIGUEL. Consejero: ARRIOLA ACIEN RAFAEL JOSE;GUILLEN JIMENEZ CECILIO. Presidente:GUILLEN JIMENEZ CECILIO. Cons.Del.Sol: GUILLEN JIMENEZ CECILIO. Consejero: JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE.Cons.Del.Sol: JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE. Consejero: LOPEZ VAZQUEZ ANGEL;LOPEZ LOPEZ MATIAS.Nombramientos. Consejero: LUNA LOPEZ RAFAEL;GARCIA MARTIN FRANCISCO ESTEBAN;LOPEZ AMAT ANDRES;GUILLENRODRIGUEZ ALEX;GUILLEN ROBLES ANTONIO JOSE;GUILLEN JIMENEZ JOSE;GUILLEN JIMENEZ MIGUEL;GUILLEN LOPEZDOLORES;GUILLEN JIMENEZ CECILIO;JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE.Presidente: GUILLEN JIMENEZ CECILIO.Vicepresid.: GUILLEN JIMENEZ MIGUEL. Secretario: GUILLEN ROBLES ANTONIO JOSE. Vicesecret.: GUILLEN LOPEZ DOLORES.Cons.Del.Sol: GUILLEN JIMENEZ CECILIO;GUILLEN RODRIGUEZ ALEX;JUAREZ NOGUEROL FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 625 , F 223, S 8, H AL 2435, I/A 74 (19.03.10).
26 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: VILLAESCUSA FUSTER CARLOS;GUILLEN LOPEZ DOLORES;GUILLEN ROBLES ANTONIOJOSE;GONZALEZ FERRE JOSE LUIS;CEREZUELA ALMENDROS JUAN ANTONIO;GUILLEN LOPEZ MARIA JOSE;GUILLENRODRIGUEZ ALEX;GUILLEN JIMENEZ MIGUEL;LOPEZ GARCIA CRISTOBAL. Otros conceptos: Revocado el poder a Don JoséGarcía Rueda, en escritura otorgada el día cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, ante Don Joaquin LópezHernández, número 4094 de protocolo, el cual no consta inscrito en el historial registral.Revocado el poder a Don Juan AntonioCerezuela Almendros, en escritura otorgada el día cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, ante Don Joaquin LópezHernández, número 4096 de protocolo, el cual no consta inscrito en el historial registral.Revocado el poder a Don Francisco EstebanGarcía Martín, enescritura otorgada el día doce de noviembre de dos mil uno,ante Don Joaquin López Hernández, número 3866 deprotocolo,el cual no consta inscrito en el historial registral.Revocado el poder a Don Agustín Peñín Cachón, en escritura otorgada el díaonce de Octubre de dos mil uno, ante Don Joaquin López Hernández, número 526 de protocolo, el cual no consta inscrito en el historialregistral. Datos registrales. T 625 , F 221, S 8, H AL 2435, I/A 66 (15.03.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUILLEN LOPEZ DOLORES;GONZALEZ FERRE JOSE LUIS;GARCIA RUEDA JOSE;CEREZUELAALMENDROS JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 625 , F 221, S 8, H AL 2435, I/A 67 (15.03.10).
Nombramientos. Apoderado: PEÑIN CACHON AGUSTIN. Datos registrales. T 625 , F 221, S 8, H AL 2435, I/A 68 (15.03.10).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA LORENZO RICARDO. Datos registrales. T 625 , F 222, S 8, H AL 2435, I/A 70 (15.03.10).
Nombramientos. Apoderado: CAÑADAS SANCHEZ ANGEL FRANCISCO. Datos registrales. T 625 , F 221, S 8, H AL 2435, I/A 69(15.03.10).
18 de Junio de 2009Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SA. Datos registrales. T 625 , F 220, S 8, H AL 2435, I/A 64 ( 8.06.09).
Reelecciones. Aud.C.Con.: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SA. Datos registrales. T 625 , F 220, S 8, H AL 2435, I/A 65 (8.06.09).
16 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: GUILLEN LOPEZ DOLORES. Datos registrales. T 625 , F 220, S 8, H AL 2435, I/A 63 ( 7.01.09).