Buscador CIF Logo

Actos BORME Aguambiente Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aguambiente Sl

Actos BORME Aguambiente Sl - B47235270

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Valladolid para Aguambiente Sl con CIF B47235270

🔙 Perfil de Aguambiente Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valladolid

Actos BORME de Aguambiente Sl

15 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 1564 , F 135, S 8, H VA 213, I/A 34 ( 8.10.19).

11 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: SALCEDO MARBAN SANTIAGO;SALCEDO MARBAN IRENE ANDREA. Datos registrales. T 1217 , F170, S 8, H VA 213, I/A 30 ( 4.10.19).

Nombramientos. Apoderado: ARIAS BRIZUELA MARIA BELEN. Datos registrales. T 1217 , F 171, S 8, H VA 213, I/A 31 ( 4.10.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ GOMEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 1217 , F 171, S 8, H VA 213, I/A 32 (4.10.19).

Nombramientos. Apoderado: LOZANO VELASCO MARIA ROCIO. Datos registrales. T 1217 , F 171, S 8, H VA 213, I/A 33 (4.10.19).

27 de Octubre de 2016
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 1217 , F 170, S 8, H VA 213, I/A 29 (20.10.16).

07 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIA ANGEL CARLOS. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GARCIA ANGEL CARLOS. Datosregistrales. T 1217 , F 169, S 8, H VA 213, I/A 27 (29.02.16).

Nombramientos. Apoderado: ORTEGA GONZALEZ MARIA DE LA PALOMA. Datos registrales. T 1217 , F 169, S 8, H VA 213, I/A28 (29.02.16).

18 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ SANDONIS MONICA;ALVAREZ GOMEZ JOSE IGNACIO;MARCOS DURANTEZ ANGELJOSE. Datos registrales. T 1217 , F 169, S 8, H VA 213, I/A 24 (11.02.15).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: HOLGUIN MERINO YOLANDA;ALVAREZ GOMEZ JOSE IGNACIO;MARCOS DURANTEZ ANGELJOSE. Datos registrales. T 1217 , F 169, S 8, H VA 213, I/A 25 (11.02.15).

Revocaciones. Apoderado: FLORES CEREZO FRANCISCO;HOLGUIN MERINO YOLANDA. Datos registrales. T 1217 , F 169, S 8,H VA 213, I/A 26 (11.02.15).

17 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: SALCEDO MARBAN AINHOA;ALVAREZ GOMEZ JOSE IGNACIO;GONZALEZ GARCIA ANGELCARLOS. Datos registrales. T 1217 , F 168, S 8, H VA 213, I/A 22 (10.02.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALCEDO MARBAN AINHOA;HOLGUIN MERINO YOLANDA;ALVAREZ GOMEZ JOSEIGNACIO;GONZALEZ GARCIA ANGEL CARLOS. Datos registrales. T 1217 , F 168, S 8, H VA 213, I/A 23 (10.02.15).

14 de Enero de 2014
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 1217 , F 166, S 8, H VA 213, I/A 20 ( 7.01.14).

18 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HOLGUIN MERINO YOLANDA;ALVAREZ GOMEZ JOSE IGNACIO;MARCOS DURANTEZ ANGELJOSE. Datos registrales. T 1217 , F 166, S 8, H VA 213, I/A 19 (11.09.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ SANDONIS MONICA;ALVAREZ GOMEZ JOSE IGNACIO;MARCOS DURANTEZ ANGELJOSE. Datos registrales. T 1217 , F 167, S 8, H VA 213, I/A 20 (11.09.13).

16 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANDONIS MONICA. Datos registrales. T 1217 , F 166, S 8, H VA 213, I/A 18 ( 7.03.12).

20 de Julio de 2009
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES CASTILLA LEON SL. Datos registrales. T 1217 , F 166, S 8, H VA 213, I/A 17 (9.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información