Actos BORME de Aguas De Las Galeras Sl
29 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: PARRA MEDIAVILLA FELIX. Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA MEDIAVILLA FELIX. Datosregistrales. T 40651 , F 9, S 8, H M 580752, I/A 35 (22.11.22).
19 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GODOY MARIA DOLORES. Datos registrales. T 40651 , F 8, S 8, H M 580752, I/A 34(12.07.22).
05 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RODRIGUEZ LIEVANA EMILIO. Datos registrales. T 40651 , F 4, S 8, H M 580752, I/A33 (28.09.21).
27 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: LAFUENTE PEREZ-LUCAS SANTIAGO. Datos registrales. T 40651 , F 2, S 8, H M 580752, I/A 32(20.07.21).
19 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ RODRIGUEZ DELIEVANA EMILIO. Datos registrales. T 40651 , F 2, S 8, H M 580752, I/A 31 (12.07.21).
03 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERRAZ SUMILLERA MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERRAZ SUMILLERA MANUEL.Datos registrales. T 36623 , F 23, S 8, H M 580752, I/A 30 (26.06.20).
19 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ATANASIO GOITIA FRANCISCO. Datos registrales. T 36623 , F 21, S 8, H M 580752, I/A 28(12.06.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCO FLORIANO ANTONIO. Datos registrales. T 36623 , F 22, S 8, H M 580752, I/A 29(12.06.19).
11 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO GALVEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 36623 , F 21, S 8, H M 580752, I/A 27 (4.06.19).
10 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: RINCON MAROTO EDUARDO. Datos registrales. T 36623 , F 20, S 8, H M 580752, I/A 25 ( 3.06.19).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CHINCHILLA PEDRO. Datos registrales. T 36623 , F 20, S 8, H M 580752, I/A 26 (3.06.19).
02 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN LUNA CESAR-ANTONIO. Datos registrales. T 36623 , F 19, S 8, H M 580752, I/A 24(26.03.19).
22 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PERAITA AGUILAR LUIS ALFONSO. Datos registrales. T 36623 , F 19, S 8, H M 580752, I/A 23(15.02.19).
20 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: PARRA MEDIAVILLA FELIX. Datos registrales. T 36623 , F 12, S 8, H M 580752, I/A 20 ( 8.11.18).
Nombramientos. Apoderado: MARBAN FERNANDEZ ISIDORO ANTONIO. Datos registrales. T 36623 , F 16, S 8, H M 580752, I/A21 ( 8.11.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE;COLIO ABRIL PABLO. Datos registrales. T 36623 , F 18, S 8, H M580752, I/A 22 ( 8.11.18).
29 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: CADENAS PARADA CRISTINA. Apo.Sol.: CADENAS PARADA CRISTINA. Datos registrales. T 31965, F 100, S 8, H M 580752, I/A 19 (20.11.17).
13 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: JARQUE URIBE CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 31965 , F 99, S 8, H M 580752, I/A 18 (3.11.17).
19 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: COLIO ABRIL PABLO. Datos registrales. T 31965 , F 96, S 8, H M 580752, I/A 17 (11.10.17).
05 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO GALVEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 31965 , F 95, S 8, H M 580752, I/A 16(26.05.17).
25 de Abril de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: PERAITA AGUILAR LUIS ALFONSO. Datos registrales. T 31965 , F 95, S 8, H M 580752, I/A 15(17.04.17).
03 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BEJAR OCHOA JUAN. Datos registrales. T 31965 , F 95, S 8, H M 580752, I/A 14 (25.11.15).
11 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: JARQUE URIBE CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 31965 , F 91, S 8, H M 580752, I/A 13(30.10.15).
17 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: DE LOS RIOS JIMENO JUAN. Datos registrales. T 31965 , F 91, S 8, H M 580752, I/A 12 (9.03.15).
16 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO. Datos registrales. T 32283 , F 23, S 8, H M 580752, I/A 5 ( 8.07.14).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ GAZQUEZ LUCAS. Datos registrales. T 32283 , F 25, S 8, H M 580752, I/A 6 ( 8.07.14).
Nombramientos. Apoderado: AMOR MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 32283 , F 27, S 8, H M 580752, I/A 7 (8.07.14).
Nombramientos. Apoderado: ALCOUCER DIAZ MANUEL. Datos registrales. T 32283 , F 27, S 8, H M 580752, I/A 8 ( 8.07.14).
Nombramientos. Apoderado: CORONA FERNANDEZ ALBERTO. Datos registrales. T 32283 , F 28, S 8, H M 580752, I/A 9 (8.07.14).
Nombramientos. Apoderado: VILLALOBOS LINARES FRANCISCO. Datos registrales. T 32283 , F 30, S 8, H M 580752, I/A 10 (8.07.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERRAZ SUMILLERA MANUEL. Datos registrales. T 32283 , F 31, S 8, H M 580752, I/A 11 (9.07.14).
04 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. Datos registrales. T 32265 , F 144, S 8, H M 580752, I/A 3(26.05.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: BEJAR OCHOA JUAN. Datos registrales. T 32265 , F 147, S 8, H M 580752, I/A 4 (26.05.14).
30 de Mayo de 2014Cambio de objeto social. EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN LOS PARRAFOS ANTERIORES QUEDALIMITADO AL HECHO DE QUE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LO INTEGRAN, DERIVEN O SE RELACIONEN CON EL OBJETODEL CONTRATO. Datos registrales. T 32265 , F 144, S 8, H M 580752, I/A 2 (23.05.14).
22 de Mayo de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 28.04.14. Objeto social: La captaci贸n transporte, tratamiento y distribuci贸n de agua, queinicialmente ser谩 su actividad principal, con c贸digo CNAE 2009 n煤mero 3600. Los trabajos t茅cnicos, administrativos e inform谩ticos parala gesti贸n de clientes, lectura de contadores, facturaci贸n. Domicilio: AVDA CAMINO DE SANTIAGO 40 (MADRID). Capital: 3.000,00