Actos BORME de Aguas Potables Del Noroeste De Madrid Sa
26 de Mayo de 2021Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16, 20, 26, 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICIONDE LOS ARTICULOS 4 BIS), 16 BIS) Y 20 BIS) EN DICHOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 38119 , F 132, S 8, H M 118185, I/A27 (19.05.21).
24 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: MARTINEZ GALA MANUEL. Consejero: SUAREZ ARNAL MANUEL;CEBRIAN AGUSTINEDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER ROQUE;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JUAN ROQUE MARIA.Presidente: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Secretario: SUAREZ ARNAL MANUEL. Consejero: MARTINEZ GALA MANUEL.Nombramientos. Consejero: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Presidente: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Consejero: DE LAHERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Vicepresid.: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Consejero: MARTINEZ GALA MANUEL.Secretario: MARTINEZ GALA MANUEL. Consejero: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JUAN ROQUE MARIA;CEBRIANHERNANDEZ ALVARO CARLOS. Datos registrales. T 38119 , F 131, S 8, H M 118185, I/A 26 (17.11.20).
04 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER;CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;CEBRIAN AGUSTINEDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Apo.Sol.: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGAJAVIER. Apoderado: MARTINEZ GALA MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRANVIDAURRAZAGA JAVIER ROQUE;MARTINEZ GALA MANUEL. Datos registrales. T 28242 , F 46, S 8, H M 118185, I/A 25(27.12.18).
24 de Mayo de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5,13 Euros. Resultante Suscrito: 254.553,55 Euros. Datos registrales. T 28242 , F 39, S8, H M 118185, I/A 24 (16.05.18).
14 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GALA MANUEL. Datos registrales. T 28242 , F 39, S 8, H M 118185, I/A 23 ( 4.12.17).
21 de Noviembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 41.842,46 Euros. Resultante Suscrito: 254.558,68 Euros. Datos registrales. T 28242 , F37, S 8, H M 118185, I/A 22 (10.11.17).
02 de Agosto de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 21.528,25 Euros. Resultante Suscrito: 296.401,14 Euros. Datos registrales. T 28242 , F36, S 8, H M 118185, I/A 21 (25.07.17).
04 de Agosto de 2016Modificaciones estatutarias. Se modifica el articulo 16 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 28242 , F 35, S 8, H M118185, I/A 20 (27.07.16).
04 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA MATA Y DE LA FUENTE GONZALO. Vicesecret.: DE LA MATA Y DE LA FUENTE GONZALO.Nombramientos. Vicesecret.: MARTINEZ GALA MANUEL. Consejero: MARTINEZ GALA MANUEL. Reelecciones. Consejero:SUAREZ ARNAL MANUEL;CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER ROQUE;DE LA HERRANVIDAURRAZAGA JUAN ROQUE MARIA. Presidente: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Secretario: SUAREZ ARNAL MANUEL. Datosregistrales. T 28242 , F 34, S 8, H M 118185, I/A 19 (27.08.15).
27 de Enero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER. Datos registrales. T 28242, F 34, S 8, H M 118185, I/A 18 (17.01.11).
30 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: CEBRIAN HERNANDO EDUARDO. Consejero: CEBRIAN HERNANDO EDUARDO.Nombramientos. Consejero: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO;DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA JAVIER ROQUE;DE LA HERRANVIDAURRAZAGA JUAN ROQUE MARIA. Presidente: CEBRIAN AGUSTIN EDUARDO. Reelecciones. Consejero: SUAREZ ARNALMANUEL;DE LA MATA Y DE LA FUENTE GONZALO. Secretario: SUAREZ ARNAL MANUEL. Vicesecret.: DE LA MATA Y DE LAFUENTE GONZALO. Datos registrales. T 7294 , F 119, S 8, H M 118185, I/A 17 (16.11.10).
16 de Febrero de 2009Reelecciones. Presidente: CEBRIAN HERNANDO EDUARDO. Secretario: SUAREZ ARNAL MANUEL. Vicesecret.: DE LA MATA YDE LA FUENTE GONZALO. Consejero: SUAREZ ARNAL MANUEL;CEBRIAN HERNANDO EDUARDO;DE LA MATA Y DE LAFUENTE GONZALO. Datos registrales. T 7294 , F 118, S 8, H M 118185, I/A 16 ( 5.02.09).