Actos BORME de Aigua De Benassal Sociedad Anonima
20 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA COLOM ELIA. Secretario: GARCIA COLOM ELIA. Consejero: MONTERDE PUIG MARILUZ;GARCIA MOYA GERARDO;MACHI BELLES DIEGO;GARCIA PUIG DAVID.Presidente: MONTERDE PUIG MARI LUZ.Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA COLOM ELIA;MONTERDE PUIG MARI LUZ. Nombramientos. Consejero: GARCIA COLOMELIA. Apo.Manc.: GARCIA COLOM ELIA. Consejero: ROIG SALVADOR ELIA. Presidente: GARCIA COLOM ELIA. Consejero:PITARCH ESCRIG MARTA;FUENTES GARCIA RAFAEL;FABREGAT FABREGAT MARIA AMPARO. Secretario: FABREGATFABREGAT MARIA AMPARO. Apo.Manc.: FABREGAT FABREGAT MARIA AMPARO. Datos registrales. T 1470, L 1032, F 69, S 8,H CS 23026, I/A 26 (13.10.23).
30 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Auditor: BARREDA ROIG JOSE MARIA. Datos registrales. T 1470, L 1032, F 68, S 8, H CS 23026, I/A 25(23.01.23).
24 de Enero de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 101.025,15 Euros. Desembolsado: 101.025,15 Euros. Resultante Suscrito: 958.747,95 Euros.Resultante Desembolsado: 958.747,95 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: AMPLIACION CAPITAL. MOD.ART. 6. Datos registrales. T 1470, L 1032, F 68, S 8, H CS 23026, I/A 24 (17.01.23).
27 de Septiembre de 2022Nombramientos. Auditor: BARREDA ROIG JOSE MARIA. Datos registrales. T 1470, L 1032, F 68, S 8, H CS 23026, I/A 23(20.09.22).
11 de Septiembre de 2020Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el Art铆culo 2潞 de los estatutos sociales, por Cambio de ObjetoSocial.. Cambio de objeto social. Explotaci贸n del manantial municipal de agua mineral; Embotellado, transporte,comercio yrealizaci贸n de controles y an谩lisis t茅cnicos y sanitarios;Prospecci贸n de mercados y promoci贸n del producto;Promoci贸necon贸mica,social,cultural de la poblaci贸n; Comercio de refrescos,zumos,lacteos. Datos registrales. T 1470, L 1032, F 68, S 8, H CS23026, I/A 22 ( 4.09.20).
25 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTERDE PUIG MARI LUZ;FABREGAT FERRER JUAN TOMAS;GARCIA MOYAGERARDO;GARCIA COLOM ELIA;GARCIA PUIG DAVID. Presidente: MONTERDE PUIG MARI LUZ. Secretario: FABREGATFERRER JUAN TOMAS. Nombramientos. Consejero: MONTERDE PUIG MARI LUZ;GARCIA COLOM ELIA;GARCIA MOYAGERARDO;MACHI BELLES DIEGO;GARCIA PUIG DAVID. Presidente: MONTERDE PUIG MARI LUZ. Secretario: GARCIA COLOMELIA. Datos registrales. T 1470, L 1032, F 66, S 8, H CS 23026, I/A 19 (12.11.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: MONTERDE PUIG MARI LUZ;FABREGAT FERRER JUAN TOMAS;ORTI CALVO MARTA. Datosregistrales. T 1470, L 1032, F 67, S 8, H CS 23026, I/A 20 (12.11.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: MONTERDE PUIG MARI LUZ;GARCIA COLOM ELIA. Datos registrales. T 1470, L 1032, F 67, S 8, HCS 23026, I/A 21 (12.11.19).
04 de Mayo de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.041.588,24 Euros. Resultante Suscrito: 857.722,80 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: Modificado el Art铆culo 6潞 de los estatutos sociales, por Reducci贸n de capital social. . Datos registrales. T1470, L 1032, F 66, S 8, H CS 23026, I/A 18 (25.04.16).
01 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: MONTERDE PUIG MARI LUZ;ORTI CALVO MARTA. Nombramientos. Apo.Manc.: MONTERDE PUIGMARI LUZ;FABREGAT FERRER JUAN TOMAS. Datos registrales. T 1244, L 807, F 202, S 8, H CS 23026, I/A 17 (22.02.16).
29 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: FUENTES GARCIA RAFAEL;MONTERDE PUIG MARI LUZ;ORTI CALVO MARTA;EDO RULL JUANMANUEL;PITARCH BELTRAN NICOLAS. Presidente: MONTERDE PUIG MARI LUZ. Secretario: ORTI CALVO MARTA.Nombramientos. Consejero: MONTERDE PUIG MARI LUZ;FABREGAT FERRER JUAN TOMAS;GARCIA MOYAGERARDO;GARCIA PUIG DAVID;GARCIA COLOM ELIA. Presidente: MONTERDE PUIG MARI LUZ. Secretario: FABREGATFERRER JUAN TOMAS. Datos registrales. T 1244, L 807, F 202, S 8, H CS 23026, I/A 16 (17.12.15).
11 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MONFERRER BAUDILIO;ORTI CALVO MARTA;COLOM PITARCHANTONIO;MONTERDE PUIG MARI LUZ. Presidente: MARTINEZ MONFERRER BAUDILIO. Secretario: MONTERDE PUIG MARILUZ. Consejero: EDO RULL JUAN MANUEL. Nombramientos. Consejero: MONTERDE PUIG MARI LUZ;ORTI CALVOMARTA;EDO RULL JUAN MANUEL;PITARCH BELTRAN NICOLAS;FUENTES GARCIA RAFAEL. Presidente: MONTERDE PUIGMARI LUZ. Secretario: ORTI CALVO MARTA. Datos registrales. T 1244, L 807, F 201, S 8, H CS 23026, I/A 14 ( 1.09.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ MONFERRER BAUDILIO. Nombramientos. Apo.Manc.: MONTERDE PUIG MARILUZ;ORTI CALVO MARTA. Datos registrales. T 1244, L 807, F 201, S 8, H CS 23026, I/A 15 ( 1.09.14).
29 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MONFERRER BAUDILIO;BELLES MIRALLES JOSE;BADAL PERIS ARCADIO;FUENTESGARCIA RAFAEL;ORTI CALVO MARTA. Presidente: MARTINEZ MONFERRER BAUDILIO. Secretario: ORTI CALVO MARTA.Nombramientos. Consejero: MARTINEZ MONFERRER BAUDILIO;ORTI CALVO MARTA;EDO RULL JUAN MANUEL;MONTERDEPUIG MARI LUZ;COLOM PITARCH ANTONIO. Presidente: MARTINEZ MONFERRER BAUDILIO. Secretario: MONTERDE PUIGMARI LUZ. Datos registrales. T 1244, L 807, F 201, S 8, H CS 23026, I/A 13 (22.10.13).
19 de Junio de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROIG BARREDA MANUEL. Datos registrales. T 1244, L 807, F 200, S 8, H CS 23026, I/A 12(11.06.12).
26 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Auditor: DOMINGUEZ CATALA SERGIO. Aud.Supl.: ROMERO BELTRAN MARIA ANGELES. Nombramientos.Auditor: ROCA MONFORT JULIO. Aud.Supl.: AGUILELLA LLINARES JORGE. Datos registrales. T 1244, L 807, F 200, S 8, H CS23026, I/A 11 (14.01.09).