Actos BORME de Aima Centros De Atencion A Mayores Sl
21 de Junio de 2018Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Domicilio social.-. Cambio de domicilio social. AVDA LAS MARISMAS100 - 41720 (PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS). Datos registrales. T 6560 , F 64, S 8, H SE118057, I/A 2 (12.06.18).
23 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: GAMARRO RODRIGUEZ ENRIQUE;FERNANDEZ LOPEZ MARIA MERCEDES;GARCIA MOTILVANIEVES;ABASCAL LAVIN ELSA;MONJE GUTIERREZ DIEGO. Datos registrales. T 20460 , F 221, S 8, H M 361936, I/A 32(16.11.16).
20 de Septiembre de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: VITALIA PLUS SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AZARBEOBRAS Y SERVICIOS SA. Representan: GARCIA SANZ FERNANDO. Nombramientos. Adm. Unico: VITALIA PLUS SA.Representan: COSCULLUELA SALINAS JOSE MARIA. Datos registrales. T 20460 , F 220, S 8, H M 361936, I/A 31 (12.09.16).
18 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: VITALIA PLUS SA. Datos registrales. T 20460 , F 219, S 8, H M 361936, I/A 30 ( 8.04.16).
16 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: OCA脩A OCA脩A ARTURO;MONJE GUTIERREZ SUSANA;PEREZ ESTEBAN MANUEL;DE LA ROCHACARRETERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 20460 , F 219, S 8, H M 361936, I/A 29 ( 8.10.15).
01 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ABASCAL LAVIN ELSA. Datos registrales. T 20460 , F 218, S 8, H M 361936, I/A 28 (24.08.15).
28 de Abril de 2015Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 20460 , F 218, S 8, H M 361936, I/A 27 (17.04.15).
24 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: VACA TERRON FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 20460 , F 218, S 8, H M 361936, I/A 26(14.11.14).
18 de Junio de 2014Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 20460 , F 217, S 8, H M 361936, I/A 25 (10.06.14).
13 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: PEREZ ESTEBAN MANUEL;DE LA ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales.T 20460 , F 217, S 8, H M 361936, I/A 24 ( 5.12.13).
12 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ FUENTES MARCOS. Nombramientos. Representan: GARCIA SANZ FERNANDO.Datos registrales. T 20460 , F 217, S 8, H M 361936, I/A 23 ( 3.12.13).
20 de Junio de 2012Cambio de domicilio social. AVDA QUITAPESARES 11 - POLIGONO EMPRESARIAL VILLAP (VILLAVICIOSA DE ODON). Datosregistrales. T 20460 , F 216, S 8, H M 361936, I/A 22 ( 7.06.12).
21 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: VACA TERRON JAVIER. Nombramientos. Representan: LOPEZ FUENTES MARCOS. Datosregistrales. T 20460 , F 216, S 8, H M 361936, I/A 21 (12.12.11).
06 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apoderado: MONTESINOS DOMINGO JOSE LUIS. Datos registrales. T 20460 , F 215, S 8, H M 361936, I/A 19(25.08.11).
Nombramientos. Apoderado: MONJE GUTIERREZ SUSANA. Datos registrales. T 20460 , F 215, S 8, H M 361936, I/A 20(25.08.11).
21 de Febrero de 2011Revocaciones. Auditor: G T C AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 20460 , F215, S 8, H M 361936, I/A 18 ( 9.02.11).
06 de Abril de 2010Nombramientos. Auditor: G T C AUDITORES SL. Datos registrales. T 20460 , F 215, S 8, H M 361936, I/A 17 (23.03.10).
03 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apoderado: GARCIA POZUELO LOPEZ PILAR;GARCIA POZUELO LOPEZ ALFONSO. Datos registrales. T 20460 ,F 214, S 8, H M 361936, I/A 16 (24.11.09).
08 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: MONTESINOS DOMINGO JOSE LUIS. Datos registrales. T 20460 , F 212, S 8, H M 361936, I/A 15(26.03.09).
23 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: AZARBE OBRAS Y SERVICIOS SA;PAREJA RODRIGUEZ JULIO;HERNANDEZ ESCRIBANOALFONSO. Presidente: PAREJA RODRIGUEZ JULIO. Secretario: HERNANDEZ ESCRIBANO ALFONSO. Con.Delegado: AZARBEOBRAS Y SERVICIOS SA. Representan: MONTESINOS DOMINGO JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: AZARBE OBRAS YSERVICIOS SA. Representan: VACA TERRON JAVIER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. 10 BIS. Administraci贸n y Representacion.- . Datos registrales. T 20460 , F 212, S8, H M 361936, I/A 14 ( 9.03.09).
12 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ARROYO BALLESTEROS ANA MARIA. Datos registrales. T 20460 , F 211, S 8, H M 361936, I/A 13(23.12.08).