Buscador CIF Logo

Actos BORME Airflow Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Airflow Sa

Actos BORME Airflow Sa - A28551422

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Airflow Sa con CIF A28551422

馃敊 Perfil de Airflow Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Airflow Sa

16 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 197, S 8, H M 34841, I/A 56 ( 9.02.23).

25 de Marzo de 2022
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 197, S 8, H M 34841, I/A 55 (19.03.22).

19 de Agosto de 2020
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 196, S 8, H M 34841, I/A 53 (12.08.20).

Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 197, S 8, H M 34841, I/A 54 (12.08.20).

27 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUANO SAIZ CONCEPCION. Reelecciones. Consejero: CASTA脩O ALVAREZ LUIS. Presidente:CASTA脩O ALVAREZ LUIS. Consejero: POLO RUANO MARIA CONCEPCION. Secretario: POLO RUANO MARIA CONCEPCION.Con.Delegado: CASTA脩O ALVAREZ LUIS;POLO RUANO MARIA CONCEPCION. Consejero: VARELA MONTEAGUDO MARIAISABEL;ALBANESE MATHIEU LAURENT. Datos registrales. T 1946 , F 196, S 8, H M 34841, I/A 52 (20.03.20).

18 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 196, S 8, H M 34841, I/A 51 (11.07.19).

18 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 195, S 8, H M 34841, I/A 50 (10.10.18).

08 de Enero de 2018
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.833,88 Euros. Desembolsado: 2.833,88 Euros. Resultante Suscrito: 429.332,82 Euros. ResultanteDesembolsado: 429.332,82 Euros. Datos registrales. T 1946 , F 195, S 8, H M 34841, I/A 49 (28.12.17).

24 de Marzo de 2017
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 194, S 8, H M 34841, I/A 47 (16.03.17).

Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 194, S 8, H M 34841, I/A 48 (16.03.17).

10 de Agosto de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 37.944,06 Euros. Resultante Suscrito: 426.498,94 Euros. Datos registrales. T 1946 , F194, S 8, H M 34841, I/A 46 ( 2.08.16).

07 de Mayo de 2015
Nombramientos. Consejero: VARELA MONTEAGUDO MARIA ISABEL;ALBANESE MATHIEU LAURENT. Datos registrales. T1946 , F 193, S 8, H M 34841, I/A 45 (28.04.15).

16 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: POLO RUANO MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 1946 , F 193, S 8, H M 34841, I/A 44 (9.04.14).

01 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ AGUADO FRANCISCO;POLO ZU脩IGA JOSE;CASTA脩O ALVAREZ LUIS. Presidente:MARQUEZ AGUADO FRANCISCO. Secretario: POLO ZU脩IGA JOSE. Con.Delegado: POLO ZU脩IGA JOSE. Nombramientos.Consejero: CASTA脩O ALVAREZ LUIS. Presidente: CASTA脩O ALVAREZ LUIS. Consejero: POLO RUANO MARIA CONCEPCION.Secretario: POLO RUANO MARIA CONCEPCION. Consejero: RUANO SAIZ CONCEPCION. Con.Delegado: CASTA脩O ALVAREZLUIS;POLO RUANO MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 1946 , F 192, S 8, H M 34841, I/A 43 (24.03.14).

05 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 192, S 8, H M 34841, I/A 43 (25.10.13).

25 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: POLO ZU脩IGA JOSE. Presidente: POLO ZU脩IGA JOSE. Consejero: FERNANDEZ SANZARMANDO. Secretario: FERNANDEZ SANZ ARMANDO. Con.Delegado: FERNANDEZ SANZ ARMANDO. Consejero: MARQUEZAGUADO FRANCISCO;ALBANESE MATHIEU LAURENT. Nombramientos. Consejero: MARQUEZ AGUADO FRANCISCO;POLOZU脩IGA JOSE;CASTA脩O ALVAREZ LUIS. Presidente: MARQUEZ AGUADO FRANCISCO. Secretario: POLO ZU脩IGA JOSE.Con.Delegado: POLO ZU脩IGA JOSE. Apoderado: POLO ZU脩IGA JOSE. Datos registrales. T 1946 , F 82, S 8, H M 34841, I/A 40(16.01.13).

Nombramientos. Apoderado: MARQUEZ AGUADO FRANCISCO. Datos registrales. T 1946 , F 191, S 8, H M 34841, I/A 41(16.01.13).

28 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 82, S 8, H M 34841, I/A 39 (16.09.11).

12 de Abril de 2011
Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n de los art铆culos 13 y 18 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 1946 ,F 82, S 8, H M 34841, I/A 38 (31.03.11).

15 de Noviembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: SEVILLANO FRUTOS JOSE LUIS. Datos registrales. T 1946 , F 82, S 8, H M 34841, I/A 37 (3.11.10).

14 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: MARQUEZ AGUADO FRANCISCO. Secretario: POLO ZU脩IGA JOSE. Consejero: SEVILLANOFRUTOS JOSE LUIS;FERNANDEZ SANZ ARMANDO;POLO ZU脩IGA JOSE;MARQUEZ AGUADO FRANCISCO. Cons.Del.Sol: POLOZU脩IGA JOSE;MARQUEZ AGUADO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: POLO ZU脩IGA JOSE. Presidente: POLO ZU脩IGAJOSE. Consejero: FERNANDEZ SANZ ARMANDO. Secretario: FERNANDEZ SANZ ARMANDO. Con.Delegado: FERNANDEZ SANZARMANDO. Consejero: MARQUEZ AGUADO FRANCISCO;SEVILLANO FRUTOS JOSE LUIS;ALBANESE MATHIEU LAURENT.Datos registrales. T 1946 , F 81, S 8, H M 34841, I/A 35 ( 2.09.10).

Nombramientos. Apoderado: ALBANESE MATHIEU LAURENT. Datos registrales. T 1946 , F 81, S 8, H M 34841, I/A 36 ( 2.09.10).

13 de Septiembre de 2010
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 80, S 8, H M 34841, I/A 33 ( 2.09.10).

Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 81, S 8, H M 34841, I/A 34 ( 2.09.10).

03 de Febrero de 2009
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 1946 , F 80, S 8, H M 34841, I/A 32 (23.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n