Actos BORME de Airmedical Products Sl
13 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BRDENK JEAN CLAUDE. Nombramientos. Adm. Unico: JOURDANNEY OLIVIER. Datosregistrales. T 42671 , F 201, S 8, H M 509364, I/A 16 ( 5.10.23).
15 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Datos registrales. T 42671 , F 201, S 8, H M 509364, I/A 15 ( 8.02.23).
03 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JOURDANNEY OLIVIER. Nombramientos. Adm. Unico: BRDENK JEAN CLAUDE. Datosregistrales. T 42671 , F 200, S 8, H M 509364, I/A 14 (27.01.23).
31 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. 20. Ejercicio social.-. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 42671 , F 200, S 8, H M509364, I/A 13 (24.10.22).
30 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: BARAMBIO DOMENECH SUSANA. Datos registrales. T 42671 , F 200, S 8, H M 509364, I/A 12(23.08.22).
13 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINOSO VESGA MARC;OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 28280 , F 63, S 8, H M 509364,I/A 11 ( 6.06.22).
09 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. C/ DOMENICO SCARLATTI 3 - LOCAL 18 B (MADRID). Datos registrales. T 28280 , F 63, S 8, H M509364, I/A 10 ( 2.06.22).
21 de Febrero de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 12.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.000,00 Euros. Datos registrales. T 28280 , F 62, S 8, H M509364, I/A 9 (14.02.22).
25 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL;REINOSO VESGA MARC. Datos registrales. T 28280 , F 61, S 8, HM 509364, I/A 8 (18.06.21).
17 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FAYOLLE ARNAUD;JOURDANNEY OLIVIER;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;REINOSO VESGAMARC. Presidente: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Nombramientos. Adm. Unico:JOURDANNEY OLIVIER. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador煤nico. Datos registrales. T 28280 , F 61, S 8, H M 509364, I/A 7 (10.05.21).
28 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 28280 , F 60, S 8, H M 509364, I/A 6 (21.04.21).
29 de Marzo de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BASTIDE LE CONFOR MEDICAL. Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOSMARTINEZ SANTIAGO;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Presidente: CAMPOS MARTINEZSANTIAGO. Secretario: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Nombramientos.Consejero: FAYOLLE ARNAUD;JOURDANNEY OLIVIER;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;REINOSO VESGA MARC. Presidente:CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Datos registrales. T 28280 , F 58, S 8, H M 509364, I/A 5(22.03.21).
16 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Nombramientos. Consejero: CAMPOS MARTINEZSANTIAGO;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO.Secretario: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Modificaciones estatutarias.modificado el art铆culo 19 de los estatutos sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 28280 , F 58, S 8, H M 509364, I/A 4 ( 6.11.17).
20 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LLOPART GARCIA LLUIS. Nombramientos. Adm. Unico: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Datosregistrales. T 28280 , F 57, S 8, H M 509364, I/A 3 (13.02.13).
11 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: LLOPART GARCIA LLUIS.Datos registrales. T 28280 , F 57, S 8, H M 509364, I/A 2 ( 1.02.11).
14 de Diciembre de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 12.11.10. Objeto social: Compra , venta importaci贸n , exportaci贸n y fabricaci贸n de aparatosy producto utilizados en el campo m茅dico... Domicilio: C/ SANCHO DAVILA 21, BAJO 3 (MADRID). Capital: 12.000,00 Euros.Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 28280 , F 56, S 8, H M 509364, I/A 1(30.11.10).