Buscador CIF Logo

Actos BORME Al-andalus Wind Power Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Al-andalus Wind Power Sl

Actos BORME Al-andalus Wind Power Sl - B70107925

Tenemos registrados 43 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Al-andalus Wind Power Sl con CIF B70107925

馃敊 Perfil de Al-andalus Wind Power Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Al-andalus Wind Power Sl

15 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: GARCIA IGLESIAS EDUARDO. Datos registrales. T 41139 , F 57, S 8, H M 447650, I/A 56 ( 7.11.23).

10 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: ECHANOVE SANCHEZ FERNANDO. Apo.Manc.: TURU I TARRE ANNA. Datos registrales. T 41139 , F57, S 8, H M 447650, I/A 55 ( 3.08.23).

07 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: EJEA LAFUENTE NOELIA. Apoderado: PLAZAS REQUENA JAVIER. Nombramientos. Apo.Manc.:REYES ASENSIO JUAN JOSE. Datos registrales. T 41139 , F 56, S 8, H M 447650, I/A 54 (28.02.23).

06 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: MILLAN RESA MIRIAN. Nombramientos. Apo.Manc.: TABOADA DIAZ-RINCON YOLANDA;TURU ITARRE ANNA;SOLIS ALVAREZ SANDRA;EJEA LAFUENTE NOELIA;LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA. Apo.Sol.: RUBIO GARCIAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41139 , F 54, S 8, H M 447650, I/A 53 (30.01.23).

04 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: ECHANOVE SANCHEZ FERNANDO;MARTIN MARTINEZ JORGE;CACERES SALAZAR PEDRO;BELDAMARIN RAFAEL. Datos registrales. T 41139 , F 53, S 8, H M 447650, I/A 52 (27.10.22).

14 de Octubre de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41139 , F 53, S 8, H M 447650, I/A 51 ( 6.10.22).

28 de Junio de 2022
Revocaciones. Apoderado: RUS OZAEZ ANTONIO. Datos registrales. T 41139 , F 53, S 8, H M 447650, I/A 50 (21.06.22).

26 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ FERNANDEZ IRENE. Datos registrales. T 41139 , F 52, S 8, H M 447650, I/A 49 (19.11.21).

02 de Marzo de 2021
Reelecciones. Representan: PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO. Adm. Unico: SAETA YIELD SA. Datos registrales. T 41139 ,F 52, S 8, H M 447650, I/A 48 (23.02.21).

19 de Febrero de 2021
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41139 , F 51, S 8, H M 447650, I/A 47 (12.02.21).

21 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: AGUADO MONTALVO DAVID. Datos registrales. T 25277 , F 78, S 8, H M 447650, I/A 45 (14.12.20).

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO;DEL VALLE CALVOMARIA DOLORES. Apo.Sol.: SALVADOR DE SANCHO RAUL;GARCIA IGLESIAS EDUARDO;FERNANDEZ PEREZ LUISALBERTO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO;DEL VALLE CALVO MARIA DOLORES;RUSOZAEZ ANTONIO;LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA. Nombramientos. Apoderado: RUS OZAEZ ANTONIO;PLAZAS REQUENAJAVIER;GARCIA IGLESIAS EDUARDO;SALVADOR DE SANCHO RAUL;SIERRA ALBERT JORGE;LASHERAS PRIETOMIGUEL;LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA;BARDAJI GARCIA LUIS. Datos registrales. T 25277 , F 78, S 8, H M 447650, I/A 46(14.12.20).

16 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25277 , F 78, S 8, H M 447650, I/A 44 (10.07.19).

09 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: BARDAJI GARCIA LUIS;MILLAN RESA MIRIAN. Datos registrales. T 25277 , F 78, S 8, H M 447650, I/A43 ( 3.07.19).

08 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Nombramientos. Representan: PEREZ DE LEMA DE LAMATA ALVARO. Datos registrales. T 25277 , F 77, S 8, H M 447650, I/A 42 (28.12.18).

08 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: SALVADOR DE SANCHO RAUL;GARCIA IGLESIAS EDUARDO;FERNANDEZ PEREZ LUISALBERTO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO;DEL VALLE CALVO MARIA DOLORES;RUSOZAEZ ANTONIO;LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA. Datos registrales. T 25277 , F 76, S 8, H M 447650, I/A 41 ( 1.10.18).

18 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25277 , F 76, S 8, H M 447650, I/A 40 (10.08.17).

19 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25277 , F 75, S 8, H M 447650, I/A 39 ( 2.12.16).

12 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO;DEL VALLE CALVOMARIA DOLORES. Datos registrales. T 25277 , F 74, S 8, H M 447650, I/A 38 ( 1.12.16).

25 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ ZU脩IGA JOSE IGNACIO;MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS;LOZANO PUEYO EPIFANIO.Datos registrales. T 25277 , F 74, S 8, H M 447650, I/A 37 (17.11.16).

15 de Junio de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25277 , F 74, S 8, H M 447650, I/A 36 ( 7.06.16).

02 de Octubre de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SAETA YIELD SA. Datos registrales. T 25277 , F 74, S 8, H M 447650, I/A 35(25.09.15).

25 de Junio de 2015
Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS, NUMERO 16 D (MADRID). Datos registrales. T 25277 , F 73, S 8, H M 447650,I/A 34 (18.06.15).

06 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ENERGIA Y RECURSOS AMBIENTALES SA. Representan: REIN ROJO LUIS. Nombramientos.Adm. Unico: SAETA YIELD SA. Representan: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Datos registrales. T 25277 , F 73, S 8, H M 447650,I/A 33 (23.02.15).

15 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25277 , F 73, S 8, H M 447650, I/A 32 ( 7.01.15).

13 de Enero de 2015
Nombramientos. Apoderado: LOZANO PUEYO EPIFANIO. Datos registrales. T 25277 , F 69, S 8, H M 447650, I/A 31 ( 5.01.15).

19 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON. Nombramientos. Representan: REIN ROJO LUIS. Datosregistrales. T 25277 , F 69, S 8, H M 447650, I/A 30 (12.12.14).

05 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25277 , F 69, S 8, H M 447650, I/A 29 (28.10.13).

18 de Julio de 2013
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 25277 , F68, S 8, H M 447650, I/A 27 (11.07.13).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Datos registrales. T 25277 , F 68, S 8, H M 447650, I/A 28(11.07.13).

10 de Julio de 2013
Reelecciones. Adm. Unico: ENERGIA Y RECURSOS AMBIENTALES SA. Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON. Datosregistrales. T 25277 , F 67, S 8, H M 447650, I/A 26 ( 3.07.13).

05 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25277 , F 67, S 8, H M 447650, I/A 25 (23.01.13).

30 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apoderado: PEREZ LORENZO JAVIER;FERNANDEZ TRESGALLO GUSTAVO. Datos registrales. T 25277 , F 67,S 8, H M 447650, I/A 24 (19.10.12).

16 de Julio de 2012
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ GONZALEZ ALBO JUAN MANUEL;GOMEZ ZAMORA ANTONIO;GOMEZ ZAMORA ANTONIO.Datos registrales. T 25277 , F 67, S 8, H M 447650, I/A 23 ( 4.07.12).

06 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: GOMEZ ZAMORA ANTONIO. Nombramientos. Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON.Datos registrales. T 25277 , F 66, S 8, H M 447650, I/A 22 (22.06.12).

15 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: LLORENTE GOMEZ EUGENIO. Nombramientos. Representan: GOMEZ ZAMORA ANTONIO.Datos registrales. T 25277 , F 66, S 8, H M 447650, I/A 21 ( 2.12.10).

26 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: IGLESIA LACHICA LEOPOLDO. Datos registrales. T 25277 , F 66, S 8, H M 447650, I/A 20 (16.11.10).

09 de Abril de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.090.445,07 Euros. Resultante Suscrito: 16.787.297,67 Euros. Datos registrales. T 25277 , F 65, S8, H M 447650, I/A 18 (29.03.10).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 368.112,03 Euros. Resultante Suscrito: 17.155.409,70 Euros. Datos registrales. T 25277 , F 66, S 8,H M 447650, I/A 19 (29.03.10).

15 de Febrero de 2010
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25277 , F 65, S 8, H M 447650, I/A 17 ( 3.02.10).

22 de Junio de 2009
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ZAMORA ANTONIO. Datos registrales. T 25277 , F 64, S 8, H M 447650, I/A 16 (10.06.09).

27 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ TRESGALLO GUSTAVO. Datos registrales. T 25277 , F 63, S 8, H M 447650, I/A 15(16.02.09).

25 de Febrero de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.111.281,60 Euros. Resultante Suscrito: 15.696.852,60 Euros. Datos registrales. T 25277 , F 62, S8, H M 447650, I/A 14 (13.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n