Buscador CIF Logo

Actos BORME Aladren Siglo Xxi Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aladren Siglo Xxi Sl

Actos BORME Aladren Siglo Xxi Sl - B50984244

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Aladren Siglo Xxi Sl con CIF B50984244

馃敊 Perfil de Aladren Siglo Xxi Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Aladren Siglo Xxi Sl

26 de Enero de 2017
Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 506/2016, AUTOFIRME DE FECHA 30/09/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LASOCIEDAD. Extinci贸n. Datos registrales. T 38711 , F 42, S 8, H B 332598, I/A 18 (18.01.17).

26 de Abril de 2013
Cambio de domicilio social. CL PARIS Num.64 ESC.B P.1 PTA.4 (BARCELONA). Datos registrales. T 38711 , F 41, S 8, H B332598, I/A 17 (17.04.13).

07 de Diciembre de 2011
Revocaciones. ADM.UNICO: GARRIDO CRISTO JOSE MIGUEL. Nombramientos. ADM.UNICO: RUIZ DE MARCOS PEDRO.Datos registrales. T 38711 , F 41, S 8, H B 332598, I/A 16 (23.11.11).

25 de Noviembre de 2011
Revocaciones. APODERADO: MICHEL ITALO LAVIN DONOSO. Nombramientos. APODERADO: PAEZ MORILLAS JOSERAMON;MASO PEQUE脩O RAFAEL;MARCELO MARTIN BILOTTA. Datos registrales. T 38711 , F 40, S 8, H B 332598, I/A 15(14.11.11).

11 de Agosto de 2011
Revocaciones. APODERADO: OSUNA CHAMBON FABRICE;LASCA OPRIS CRISTIAN EUGEN;LOPEZ MORA GUSTAVOADOLFO;EVA BRENDEMUHL;SANCHEZ SOLER JESUS;MARTINEZ ROIG FRANCESC XAVIER. Nombramientos. APODERADO:VILLAVERDE CARNEVALLI RAMON;MICHEL ITALO LAVIN DONOSO. Datos registrales. T 38711 , F 38, S 8, H B 332598, I/A 13 (1.08.11).

Revocaciones. ADM.UNICO: ALASDAIR DEREK MURDOCH. Nombramientos. ADM.UNICO: GARRIDO CRISTO JOSE MIGUEL.Datos registrales. T 38711 , F 37, S 8, H B 332598, I/A 12 ( 1.08.11).

Nombramientos. APODERADO: SERRA SEDE脩O FRANCISCO JOSE;RUIZ DE MARCOS PEDRO. Datos registrales. T 38711 , F39, S 8, H B 332598, I/A 14 ( 1.08.11).

16 de Febrero de 2010
Revocaciones. ADM.UNICO: ERIC JEAN YVES DANIEL ANDRE. Nombramientos. ADM.UNICO: ALASDAIR DEREK MURDOCH.Datos registrales. T 38711 , F 37, S 8, H B 332598, I/A 11 ( 3.02.10).

30 de Junio de 2009
Revocaciones. APODERADO: EVA BRENDEMUHL GUBERT. Datos registrales. T 38711 , F 36, S 8, H B 332598, I/A 9 (18.06.09).

Nombramientos. APODERADO: EVA BRENDEMUHL;SANCHEZ SOLER JESUS;MARTINEZ ROIG FRANCESC XAVIER. Datosregistrales. T 38711 , F 36, S 8, H B 332598, I/A 10 (18.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n