Actos BORME de Alas Courier Sl
01 de Marzo de 2023Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T20850 , F 107, S 8, H M 80784, I/A 44 (22.02.23).
03 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Datos registrales. T 20850 , F 107, S 8, H M 80784, I/A 43(27.07.22).
06 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO;SANCHEZ DE LEON FERNANDEZ JUAN LUIS;MARTINEZ MARTINEZMARTIN. Apo.Manc.: REAL CAMACHO NOELIA;FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 20850 , F 107, S 8, H M80784, I/A 42 (29.06.22).
14 de Junio de 2022Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 20850 , F107, S 8, H M 80784, I/A 41 ( 7.06.22).
08 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Presidente: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. Nombramientos. Presidente: DELMAS YVES PIERRE LOUIS.Datos registrales. T 20850 , F 106, S 8, H M 80784, I/A 40 ( 1.03.22).
03 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: REAL CAMACHO NOELIA. Datos registrales. T 20850 , F 105, S 8, H M 80784, I/A 35 (24.02.22).
Nombramientos. Apoderado: VILLEGAS SANCHEZ MARTA ELENA. Datos registrales. T 20850 , F 105, S 8, H M 80784, I/A 36(24.02.22).
Nombramientos. Apoderado: NIETO PALMEIRO CONSOLACION. Datos registrales. T 20850 , F 105, S 8, H M 80784, I/A 37(24.02.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN;REAL CAMACHO NOELIA;NIETO PALMEIROCONSOLACION;VILLEGAS SANCHEZ MARTA ELENA;SANCHEZ DE LEON FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 20850 , F106, S 8, H M 80784, I/A 38 (24.02.22).
Revocaciones. Apoderado: FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO;SANCHEZ DE LEON JUAN LUIS. Datos registrales. T 20850 , F 106,S 8, H M 80784, I/A 39 (24.02.22).
28 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN;REAL CAMACHO NOELIA;VILLEGAS SANCHEZ MARTAELENA;SANCHEZ DE LEON FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 20850 , F 105, S 8, H M 80784, I/A 34 (21.02.22).
01 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLANUEVA RUIZ JULIO ALEXANDER. VsecrNoConsj: PAREJO BALLESTEROS DANIEL.Secretario: URBANO JIMENEZ JAVIER. VsecrNoConsj: GONZALEZ ORTEGA JUAN MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj:LUJAN ESPI ALBERTO. VsecrNoConsj: GARCIA STUYCK MIGUEL LIVINIO. Consejero: DELMAS YVES PIERRE LOUIS. Datosregistrales. T 20850 , F 104, S 8, H M 80784, I/A 32 (24.09.21).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GEOPOST ESPA脩A SL. Datos registrales. T 20850 , F 104, S 8, H M 80784, I/A 33(24.09.21).
01 de Marzo de 2021Revocaciones. Auditor: ABACO AUDITORES CONSULTORES SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datosregistrales. T 20850 , F 103, S 8, H M 80784, I/A 31 (22.02.21).
14 de Enero de 2021Otros conceptos: RECTIFICADO EL DNI DEL APODERADO DON MARTIN MARTINEZ MARTINEZ. Datos registrales. T 20850 , F103, S 8, H M 80784, I/A 30 ( 7.01.21).
13 de Noviembre de 2020Cambio de domicilio social. C/ MAR EGEO, 1. (SAN FERNANDO DE HENARES). Datos registrales. T 20850 , F 103, S 8, H M80784, I/A 29 ( 5.11.20).
26 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: CAMACHO INIESTA MARIALUISA;VILLANUEVA RUIZ JULIO ALEXANDER;NAVARRO PEROMINGO ALBERTO. Presidente: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA.Secretario: URBANO JIMENEZ JAVIER. VsecrNoConsj: PAREJO BALLESTEROS DANIEL;GONZALEZ ORTEGA JUAN MARIA.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T20850 , F 101, S 8, H M 80784, I/A 26 (18.12.19).
Modificaciones estatutarias. 9. Organos de Gobierno de la Sociedad. 11. Junta General. 12. Convocatoria de la Junta. 13. JuntaGeneral. 14. Acta de la Junta. 16. Organo de Administraci贸n. Consejo. 17. Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 20850 , F102, S 8, H M 80784, I/A 27 (18.12.19).
Nombramientos. Con.Delegado: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. Datos registrales. T 20850 , F 103, S 8, H M 80784, I/A 28(18.12.19).
12 de Diciembre de 2018Nombramientos. Auditor: ABACO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 20850 , F 101, S 8, H M 80784, I/A 25 (3.12.18).
27 de Junio de 2018Otros conceptos: El nombre de la calle donde tiene la Sociedad el domicilio social, Paraje de Vaciabotas- Nave Tipsa, S/N, ParcelaIMC-3陋 Sector Sup 1-2 San Fernando de Henares (Madrid) es en la actualidad: Avenida de Marcelino Camacho, n潞 13, San Fernandode Henares (Madrid). Datos registrales. T 20850 , F 101, S 8, H M 80784, I/A 24 (20.06.18).
09 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 20850 , F 100, S 8, H M 80784, I/A 23 ( 2.08.17).
08 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: REAL CAMACHO NOELIA;FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 20850 , F 100, S 8,H M 80784, I/A 22 (28.02.17).
19 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE LEON JUAN LUIS. Datos registrales. T 20850 , F 99, S 8, H M 80784, I/A 21(11.10.16).
10 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 16.- RETRIBUCION.- . Datos registrales. T 20850 , F 99, S 8, H M80784, I/A 20 ( 3.02.15).
03 de Noviembre de 2014Cambio de domicilio social. PRAJE VACIABOTAS - NAVE TIPSA, S/N, PARCELA 11-A (SAN FERNANDO DE HENARES). Datosregistrales. T 20850 , F 99, S 8, H M 80784, I/A 19 (24.10.14).
18 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 20850 , F 99, S 8, H M 80784, I/A 18 ( 7.08.14).
13 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 20850 , F 98, S 8, H M 80784, I/A 17 ( 5.12.12).
11 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE LEON JUAN LUIS. Datos registrales. T 20850 , F 98, S 8, H M 80784, I/A 16(30.12.11).
10 de Noviembre de 2011Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 16 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 20850 , F 97, S8, H M 80784, I/A 15 (27.10.11).