Buscador CIF Logo

Actos BORME Albatros Alcazar Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Albatros Alcazar Sociedad Anonima

Actos BORME Albatros Alcazar Sociedad Anonima - A13354048

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Ciudad Real para Albatros Alcazar Sociedad Anonima con CIF A13354048

馃敊 Perfil de Albatros Alcazar Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Ciudad Real

Actos BORME de Albatros Alcazar Sociedad Anonima

10 de Febrero de 2012
Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: ALBATROS LOGISTICA ALCAZAR, SOCIEDAD LIMITADA. ALBITRENMANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n. Datos registrales. T 312 , F 84, S 8, H CR11946, I/A 22 (27.01.12).

07 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DIAZ DAMIAN. Datos registrales. T 312 , F 84, S 8, H CR 11946, I/A 21 (24.10.11).

29 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA ANTONIA RAMOS PEDRO. Datos registrales. T 312 , F 84, S 8, H CR 11946, I/A 20(11.07.11).

15 de Julio de 2011
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DIAZ DAMIAN. Datos registrales. T 312 , F 83, S 8, H CR 11946, I/A 19 ( 6.07.11).

14 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: GIL FERRERO LUIS;GRANDA GONZALEZ ALFONSO;GIL FERRERO LUIS;GRANDA GONZALEZALFONSO;DELGADO FERNANDEZ ARTURO;CRISOL DIAZ GERMAN. Apoderado: GIL DIEZ TICIO JOSE RAMON. Apo.Manc.:GALAVIS VALCARCEL ENRIQUE;DELGADO FERNANDEZ ARTURO;GIL FERRERO LUIS;GRANDA GONZALEZALFONSO;MEDINA ESCRIBANO SIXTO;HARO GONZALEZ VANESA;RIVAS ORTEGA ANA - BELEN Datos registrales. T 312 , F82, S 8, H CR 11946, I/A 17 (28.02.11).

Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ DIAZ DAMIAN;MEDINA ESCRIBANO SIXTO;RIVAS ORTEGA ANA BELEN;HAROGONZALEZ VANESA;TEJERO FERNANDEZ-MONTES DIEGO. Datos registrales. T 312 , F 83, S 8, H CR 11946, I/A 18 (28.02.11).

03 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ ALVAREZ JUAN;GARCIA GALLEGO DANIEL. Nombramientos. Consejero: URKIJOGOITIA ENRIQUE;CASTRO LOPEZ AVELINO. Datos registrales. T 312 , F 82, S 8, H CR 11946, I/A 15 (15.01.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BUSTAMANTE CORTIJO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: GARCIA PRIETORAIMUNDO. Datos registrales. T 312 , F 82, S 8, H CR 11946, I/A 16 (15.01.11).

30 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: GIL FERRERO LUIS;GRANDA GONZALEZ ALFONSO;MEDINA ESCRIBANO SIXTO;HAROGONZALEZ VANESA;RIVAS ORTEGA ANA - BELEN. Datos registrales. T 312 , F 81, S 8, H CR 11946, I/A 14潞 ( 5.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n