Buscador CIF Logo

Actos BORME Albemarle Spain Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Albemarle Spain Sl

Actos BORME Albemarle Spain Sl - B63702104

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Albemarle Spain Sl con CIF B63702104

🔙 Perfil de Albemarle Spain Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Albemarle Spain Sl

05 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NARWOLD KAREN. Nombramientos. Adm. Solid.: CHROMY DAVID;DUNBAR AMY

05 de Enero de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: ESCRIVA DE ROMANI MORALES-ARCE IGNACIO;ROVIRA BENITEZ JAVIER;ROMERO PADIERNASORAYA;LANZAS ROTA BLANCA GUADALUPE;SERRANO CEBRIA ANA;RAMOS LAGUNA ANGEL. Datos registrales. T 39707 ,F 104, S 8, H M 705548, I/A 7 (29.12.22).

16 de Diciembre de 2022
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41 4ª (MADRID). Datos registrales. T 39707 , F 104, S 8, H M 705548, I/A 6 (11.12.22).

15 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: INTERTRUST (SPAIN) SL. Datos registrales. T 39707 , F 103, S 8, H M 705548, I/A 5 ( 7.12.22).

30 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: SANTOS INFANTE GUILLERMO. Datos registrales. T 39707 , F 102, S 8, H M 705548, I/A 4(23.08.22).

06 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: DUNBAR AMY MASSEY;WOLFF WILLIAM. Apo.Manc.: TERREN CONNER ALEXANDRA;SCHMIDTDENNIS DICK. Datos registrales. T 39707 , F 101, S 8, H M 705548, I/A 3 (28.04.21).

07 de Noviembre de 2019
Cambio de domicilio social. C/ MALDONADO 4 - BAJO D (MADRID). Datos registrales. T 39707 , F 101, S 8, H M 705548, I/A 2(30.10.19).

08 de Octubre de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: ISABELLE MIESING. Datos registrales. T 37151 , F 160, S 8, H B 296319, I/A 7 (28.09.18).

Revocaciones. APODERADO: NIEK VAN T KLOOSTER;LEONARDUS PETRUS WILHELMUS MAAS;RAYMOND HURLEY;TOLEDOHERNANDEZ JOSE ANTONIO;CHARLES KEVIN WILSON;JENNIFER EMERSON ROSHTO;KAY CLAIRE ZIMMERMAN;DONALDWAYNE ROBERIE;ALBIÑANA CILVETI IGNACIO;PEREZ RIVARES JUAN ANTONIO;ECHENIQUE CONDE PABLO;GIMENEZALIAGA MARTA;BAGARIA MATEOS EDUARDO. Datos registrales. T 37151 , F 160, S 8, H B 296319, I/A 8 (28.09.18).

22 de Julio de 2011
Revocaciones. ADM.UNICO: LUTHER CLARENCE KISSAM. Nombramientos. ADM.UNICO: KAREN NARWOLD. Datosregistrales. T 37151 , F 160, S 8, H B 296319, I/A 6 (13.07.11).

19 de Agosto de 2009
Cambio de domicilio social. AV DE LES CORTS CATALANES Num.7 P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES). Datos registrales. T37151 , F 160, S 8, H B 296319, I/A 5 ( 7.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información