Buscador CIF Logo

Actos BORME Alcahuz Distribuciones Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Alcahuz Distribuciones Sa

Actos BORME Alcahuz Distribuciones Sa - A28924405

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Alcahuz Distribuciones Sa con CIF A28924405

馃敊 Perfil de Alcahuz Distribuciones Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Alcahuz Distribuciones Sa

09 de Febrero de 2023
Reelecciones. Consejero: ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR;RAMOS COVARRUBIAS GABRIEL;ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL.Presidente: ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR. Vicepresid.: ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL. Secretario: RAMOS COVARRUBIASGABRIEL. Cons.Del.Sol: ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR;ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL. Datos registrales. T 32364 , F 144,S 8, H M 79769, I/A 26 ( 2.02.23).

12 de Mayo de 2022
Nombramientos. Auditor: MU脩IZ GRIJALVO AUDITORES SL. Datos registrales. T 32364 , F 144, S 8, H M 79769, I/A 25 (5.05.22).

05 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL;ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL;ALCAHUZ VILLAVERDEVICTOR;RAMOS COVARRUBIAS GABRIEL. Presidente: ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL. Vicepresid.: ALCAHUZ VILLAVERDEVICTOR. Secretario: RAMOS COVARRUBIAS GABRIEL. Cons.Del.Sol: ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL;ALCAHUZ VILLAVERDEVICTOR;ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL. Nombramientos. Consejero: ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR;RAMOSCOVARRUBIAS GABRIEL;ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL. Presidente: ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR. Vicepresid.: ALCAHUZVILLAVERDE GABRIEL. Secretario: RAMOS COVARRUBIAS GABRIEL. Cons.Del.Sol: ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR;ALCAHUZVILLAVERDE GABRIEL. Datos registrales. T 32364 , F 144, S 8, H M 79769, I/A 24 (29.08.19).

21 de Noviembre de 2018
Otros conceptos: Revocado el nombramiento de Alberto Carrasco Blazquez como auditor titular y de Do帽a Isabel M陋 Garc铆a Sanchezcomo auditora suplente, para el ejercicio 2017. Datos registrales. T 32364 , F 143, S 8, H M 79769, I/A 23 (14.11.18).

21 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCAHUZ FERNANDEZ JOSE;ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL. Presidente: ALCAHUZFERNANDEZ JOSE. Consejero: ALCAHUZ FERNANDEZ SALVADOR. Vicepresid.: ALCAHUZ FERNANDEZ SALVADOR.Cons.Del.Sol: ALCAHUZ FERNANDEZ SALVADOR;ALCAHUZ FERNANDEZ JOSE;ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL. Consejero:RAMOS COVARRUBIAS GABRIEL. Secretario: RAMOS COVARRUBIAS GABRIEL. Nombramientos. Consejero: ALCAHUZFERNANDEZ PASCUAL;ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL;ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR;RAMOS COVARRUBIAS GABRIEL.Presidente: ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL. Vicepresid.: ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR. Secretario: RAMOS COVARRUBIASGABRIEL. Cons.Del.Sol: ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL;ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR;ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL.Datos registrales. T 32364 , F 143, S 8, H M 79769, I/A 22 ( 9.06.16).

14 de Junio de 2016
Nombramientos. Auditor: CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO. Aud.Supl.: GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA. Datos registrales. T32364 , F 143, S 8, H M 79769, I/A 21 ( 6.06.16).

17 de Junio de 2015
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 20& EL CESE DE ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL COMOCONSEJERO Y CONSEJERO DELEGADO, DEBIENDO QUEDAR VIGENTE EN DICHOS CARGOS POR LA INSCRIPCION 17&.Datos registrales. T 32364 , F 142, S 8, H M 79769, I/A 20 (10.12.14).

19 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL. Secretario: ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL. Cons.Del.Sol:ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL. Nombramientos. Consejero: RAMOS COVARRUBIAS GABRIEL. Secretario: RAMOSCOVARRUBIAS GABRIEL. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 10.588,00 Euros. Desembolsado: 10.588,00 Euros. Resultante Suscrito:70.588,00 Euros. Resultante Desembolsado: 70.588,00 Euros. Datos registrales. T 32364 , F 142, S 8, H M 79769, I/A 20 (10.12.14).

23 de Septiembre de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 101,21 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:7.600,00 Euros. Desembolsado: 7.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 67.600,00 Euros. Resultante Desembolsado: 67.600,00 Euros.Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: HORECALMACEN SL. Datos registrales. T 4857 , F 118, S 8, H M 79769, I/A 19 (15.09.14).

03 de Julio de 2013
Nombramientos. Auditor: CARRASCO BLAZQUEZ ALBERTO. Aud.Supl.: GARCIA SANCHEZ ISABEL MARIA. Datos registrales. T

21 de Marzo de 2012
Reelecciones. Consejero: ALCAHUZ FERNANDEZ JOSE;ALCAHUZ FERNANDEZ PASCUAL. Secretario: ALCAHUZ FERNANDEZPASCUAL. Presidente: ALCAHUZ FERNANDEZ JOSE. Consejero: ALCAHUZ FERNANDEZ SALVADOR. Vicepresid.: ALCAHUZFERNANDEZ SALVADOR. Cons.Del.Sol: ALCAHUZ FERNANDEZ SALVADOR;ALCAHUZ FERNANDEZ JOSE;ALCAHUZFERNANDEZ PASCUAL. Datos registrales. T 4857 , F 117, S 8, H M 79769, I/A 17 ( 8.03.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n