Actos BORME de Alcala 534 Sl
10 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: CUBERIA VIVANCOS JOSE LUIS;MERCHAN PRIETO RICARDO;GARCIA VERA PEDRO. Apoderado:GARCIA VERA PEDRO;YAGUE PALACIO SUSANA PILAR;MORALES PRIETO FRANCISCO. Datos registrales. T 12013 , F 213, S8, H M 189041, I/A 23 ( 3.10.23).
07 de Agosto de 2023Reelecciones. Auditor: ARCOASA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 12013 , F 213, S 8, H M 189041, I/A 22 (31.07.23).
11 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MORALES PRIETO FRANCISCO. Datos registrales. T 12013 , F 213, S 8, H M 189041, I/A 21(30.03.23).
05 de Abril de 2021Cambio de domicilio social. C/ VIRGEN DE LA PAZ 8 (MADRID). Datos registrales. T 12013 , F 212, S 8, H M 189041, I/A 20(25.03.21).
31 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: ARCOASA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 12013 , F 212, S 8, H M 189041, I/A 19 (23.12.20).
07 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: ARCOASA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 12013 , F 212, S 8, H M 189041, I/A 18 (28.08.17).
19 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: MERCHAN PRIETO RICARDO;ESCOBAR CABANILLAS SERGIO. Datos registrales. T 12013 , F 212,S 8, H M 189041, I/A 17 (12.01.17).
05 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: MORALES PRIETO FRANCISCO. Datos registrales. T 12013 , F 211, S 8, H M 189041, I/A 16(24.04.15).
18 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: ARCOASA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 12013 , F 211, S 8, H M 189041, I/A 15 ( 7.08.14).
19 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ RIBE MARTA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ LOPEZ PABLO. Datosregistrales. T 12013 , F 211, S 8, H M 189041, I/A 14 (11.03.13).
23 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: ARCOASA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 12013 , F 211, S 8, H M 189041, I/A 13 (13.12.11).