Actos BORME de Aldesa Energias Renovables Sl
05 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: GUERRERO CORDERO JOSE MARIA;APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD. Datos registrales. T40672 , F 153, S 8, H M 371329, I/A 70 (28.11.23).
Nombramientos. Apoderado: ZHENG QI. Datos registrales. T 40672 , F 154, S 8, H M 371329, I/A 71 (28.11.23).
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 40672 , F 155, S 8, H M 371329, I/A 72(28.11.23).
26 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO VENA JOAQUIN. Apoderado: FLETES RINCON JOSE DAVID. Apo.Manc.: FLETES RINCONJOSE DAVID;ALONSO VENA JOAQUIN. Datos registrales. T 40672 , F 153, S 8, H M 371329, I/A 69 (19.09.23).
31 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: REY GOMEZ BORJA. Datos registrales. T 40672 , F 152, S 8, H M 371329, I/A 68 (24.05.23).
09 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Apo.Manc.: GARCIA RAMIREZ MANUEL;ARGUELLES DE BUSTILLO JOSEMARIA. Datos registrales. T 40672 , F 152, S 8, H M 371329, I/A 67 ( 2.05.23).
18 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ MORENO FELIX JOSE. Datos registrales. T 40672 , F 152, S 8, H M 371329, I/A 66(11.04.23).
27 de Marzo de 2023Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 65陋 el nombramiento como Administrador Mancomunado de FERNANDEZ RUIZALEJANDRO, siendo lo correcto YOUYOU ZHANG. Datos registrales. T 40672 , F 151, S 8, H M 371329, I/A 65 (10.03.23).
17 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZ RUIZALEJANDRO. Datos registrales. T 40672 , F 151, S 8, H M 371329, I/A 65 (10.03.23).
17 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: REY GOMEZ BORJA. Datos registrales. T 40672 , F 150, S 8, H M 371329, I/A 64 (10.01.23).
28 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: DE ANGULO HIDALGO GERONIMO. Datos registrales. T 40672 , F 150, S 8, H M 371329, I/A 63(20.12.22).
12 de Diciembre de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 62陋 la revocaci贸n de los poderes mancom. y solidar. de JOAQUIN ALONSOVENA y MATILDE FERNANDEZ RUIZ, siendo lo correcto 煤nicamente la revocaci贸n de los poderes mancom. inscritos en la 50陋 y 46陋respectivamente. Datos registrales. T 40672 , F 149, S 8, H M 371329, I/A 62 (21.11.22).
Otros conceptos: La revocaci贸n del poder conferido a favor de don Joaqu铆n Alonso Vena y do帽a Matilde Fernandez Ruiz por lainscripci贸n 62陋, lo es 煤nicamente en cuanto a las facultades conferidas con caracter mancomunado, en el acuerdo segundo de lasinscripciones 50陋 y 46 repectivamente. Datos registrales. T 40672 , F 149, S 8, H M 371329, I/A 62 (21.11.22).
28 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA RAMIREZ MANUEL;SANCHEZ DUE脩AS RUBEN MANUEL;NU脩EZ MORENOFELIX;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO;CANTERO GARCIA JUAN CARLOS;FRIAS CHICHARRO SARA;ARGUELLES DEBUSTILLO JOSE MARIA;VAZQUEZ ALVAREZ JORGE;PALLARES MORANO MARIA LUISA;COBO ESPEJO JESUS. Apoderado:MEDIAVILLA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ RUIZ MATILDE;ALONSO VENA JOAQUIN. Datosregistrales. T 40672 , F 149, S 8, H M 371329, I/A 62 (21.11.22).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: BERROCAL CASQUERO JORGE;BERROCAL CASQUERO JORGE. Apo.Manc.: BERROCAL CASQUEROJORGE. Nombramientos. Apoderado: BERROCAL CASQUERO JORGE;BERROCAL CASQUERO JORGE. Datos registrales. T40672 , F 148, S 8, H M 371329, I/A 61 (14.11.22).
26 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA RAMIREZ MANUEL;SANCHEZ DUE脩AS RUBEN MANUEL;NU脩EZ MORENOFELIX;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO;CANTERO GARCIA JUAN CARLOS;FRIAS CHICHARRO SARA;ARGUELLES DEBUSTILLO JOSE MARIA;RAMOS GARCIA LUIS;COBO ESPEJO JESUS;VAZQUEZ ALVAREZ JORGE;REY GOMEZGUILLERMO;FLETES RINCON JOSE DAVID;BERROCAL CASQUERO JORGE;PALLARES MORA脩O MARIA LUISA;MEDIAVILLAMARTIN MARIA ANGELES;ALONSO VENA JOAQUIN;ZHANG YING;QUAN LIN;AIMIN JIANG;ZHANG YOUYOU. Datos registrales.T 40672 , F 148, S 8, H M 371329, I/A 60 (19.09.22).
27 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: ZHANG YING. Datos registrales. T 40672 , F 147, S 8, H M 371329, I/A 59 (19.07.22).
19 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: PALLARES MORA脩O MARIA LUISA. Nombramientos. Apoderado: PALLARES MORA脩O MARIALUISA. Datos registrales. T 40672 , F 146, S 8, H M 371329, I/A 58 (12.07.22).
04 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRERO CORDERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 40672 , F 146, S 8, H M 371329, I/A 57(26.04.22).
02 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: RAUL GARCIA YEBRA. Datos registrales. T 40672 , F 145, S 8, H M 371329, I/A 56 (25.11.21).
16 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: QUINTERO BERGANZA FRANCISCO. Datos registrales. T 40672 , F 145, S 8, H M 371329, I/A 54 (9.07.21).
Nombramientos. Apoderado: LANDAZURI PLAZA MARIA BEGO脩A. Datos registrales. T 40672 , F 145, S 8, H M 371329, I/A 55 (9.07.21).
08 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: FLETES RINCON JOSE DAVID. Datos registrales. T 40672 , F 143, S 8, H M 371329, I/A 52 (1.07.21).
Nombramientos. Apoderado: BERROCAL CASQUERO JORGE;FRIAS CHICHARRO SARA. Datos registrales. T 40672 , F 144, S8, H M 371329, I/A 53 ( 1.07.21).
17 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA LOPEZ SERGIO. Datos registrales. T 40672 , F 143, S 8, H M 371329, I/A 51 (10.03.21).
23 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO VENA JOAQUIN. Datos registrales. T 40672 , F 142, S 8, H M 371329, I/A 50 (16.02.21).
22 de Febrero de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ALDESA GESTION DE ENERGIAS RENOVABLES SL. GLOBAL HYPETROS SL.LOS ALTOS DE RUEDA, SL. Datos registrales. T 40672 , F 140, S 8, H M 371329, I/A 49 (15.02.21).
15 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;LERIDA GARCIA RICARDO. Apo.Manc.: LOPEZ DE FORONDAPEREZ MIGUEL;LERIDA GARCIA RICARDO. Apo.Sol.: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL. Datos registrales. T 40672 , F 140,S 8, H M 371329, I/A 48 ( 8.12.20).
24 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: BERROCAL CASQUERO JORGE. Apo.Manc.: BERROCAL CASQUERO JORGE. Datos registrales. T35578 , F 139, S 8, H M 371329, I/A 47 (17.11.20).
23 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ RUIZ MATILDE. Datos registrales. T 35578 , F 138, S 8, H M 371329, I/A 46(16.11.20).
21 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: LANDAZURI PLAZA MARIA BEGO脩A. Datos registrales. T 35578 , F 137, S 8, H M 371329, I/A 45(14.08.20).
24 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL. Datos registrales. T 35578 , F 137, S 8, H M 371329, I/A 44(19.07.20).
16 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ RUIZ MATILDE;FERNANDEZ RUIZ ISABEL;FERNANDEZ RUIZ MERCEDES. Apo.Sol.:ARENAS BRUALLA JOSE LUIS. Datos registrales. T 35578 , F 136, S 8, H M 371329, I/A 43 ( 9.07.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: IBA脩EZ CELADA ANTONIO. Datos registrales. T 35578 , F 135, S 8, H M 371329, I/A 41 (17.06.20).
Revocaciones. Apo.Manc.: VAQUERO COLLADO RAUL. Nombramientos. Apoderado: MEDIAVILLA MARTIN MARIA DE LOSANGELES. Datos registrales. T 35578 , F 136, S 8, H M 371329, I/A 42 (17.06.20).
30 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: PEDROSILLO MARTY PABLO. Datos registrales. T 35578 , F 135, S 8, H M 371329, I/A 40 (23.03.20).
21 de Enero de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 46.086,00 Euros. Datos registrales. T 35578 , F 133, S 8, H M371329, I/A 38 (15.01.20).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 46.087,00 Euros. Datos registrales. T 35578 , F 134, S 8, H M371329, I/A 39 (15.01.20).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: DE ANGULO HIDALGO GERONIMO. Datos registrales. T 35578 , F 132, S 8, H M 371329, I/A 37(25.03.19).
27 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: CORDOBA FERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 35578 , F 132, S 8, H M 371329, I/A 36 (20.03.19).
18 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: DOMINGO VARONA JUAN CARLOS;MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO;MATANZOCABALLERO FRANCISCO JAVIER;ARROYO GARCIA JOSE RAMON;RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE;HILLA MERCHANGUILLERMO. Datos registrales. T 35578 , F 132, S 8, H M 371329, I/A 35 ( 8.01.19).
05 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: TORRES PAREDES MIGUEL;DOMINGUEZ SANTOS JULIO. Datos registrales. T 35578 , F 131, S 8, HM 371329, I/A 34 (29.05.18).
30 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: BURGOS BLANCO CONCEPCION. Nombramientos. Apo.Sol.: RAUL GARCIA YEBRA;BERROCAL
27 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ARENAS BRUALLA JOSE LUIS. Datos registrales. T 35578 , F 130, S 8, H M 371329, I/A 32 (15.11.17).
06 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: CAVIA BA脩ALES GERARDO. Datos registrales. T 35578 , F 130, S 8, H M 371329, I/A 31 (26.10.17).
25 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: DUARTE I MACARRO ESTHER. Datos registrales. T 35578 , F 130, S 8, H M 371329, I/A 30 (18.05.17).
03 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: PALLARES MORA脩O MARIA LUISA. Datos registrales. T 25917 , F 197, S 8, H M 371329, I/A 28(24.03.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: LERIDA GARCIA RICARDO. Datos registrales. T 35578 , F 130, S 8, H M 371329, I/A 29 (24.03.17).
10 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: CAVIA BA脩ALES GERARDO. Datos registrales. T 25917 , F 196, S 8, H M 371329, I/A 27 ( 2.02.17).
24 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: BURGOS BLANCO CONCEPCION. Datos registrales. T 25917 , F 196, S 8, H M 371329, I/A 26(17.01.17).
02 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS;DOMINGUEZ SANTOSJULIO;NU脩EZ MORENO FELIX. Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA RAMIREZ MANUEL;TORRES PAREDESMIGUEL;SANCHEZ DUE脩AS RUBEN MANUEL;NU脩EZ MORENO FELIX;FERNANDEZ ROMERO ALFONSO;CANTERO GARCIAJUAN CARLOS;FRIAS CHICHARRO SARA;QUINTERO BERGANZA FRANCISCO;CORDOBA FERNANDEZ JOSE;ARGUELLES DEBUSTILLO JOSE MARIA;PEDROSILLO MARTY PABLO;VAZQUEZ ALVAREZ JORGE;GARCIA LOPEZ SERGIO;DOMINGUEZSANTOS JULIO;LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;PALLARES MORANO MARIA LUISA;VAQUERO COLLADO RAUL;COBOESPEJO JESUS. Datos registrales. T 25917 , F 195, S 8, H M 371329, I/A 25 (23.12.16).
23 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: LERIDA GARCIA RICARDO. Datos registrales. T 25917 , F 194, S 8, H M 371329, I/A 24 (15.11.16).
22 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Presidente: ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Cons.Del.Sol:ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Consejero: ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA;ALDESA CONCESIONES SL.SecreNoConsj: FERNANDEZ RUIZ ISABEL. VsecrNoConsj: VEGA SORROSAL LUIS. Representan: FERNANDEZ RUIZALEJANDRO;NU脩EZ MORENO FELIX;QUINTERO BERGANZA FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZRUIZ ALEJANDRO;NU脩EZ MORENO FELIX. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 25917 , F 194, S 8, H M 371329, I/A 23 (12.08.16).
17 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Datos registrales. T 25917 , F 193, S 8, H M 371329, I/A 22 (6.05.16).
28 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Representan: BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Nombramientos. Representan: QUINTEROBERGANZA FRANCISCO. Datos registrales. T 25917 , F 193, S 8, H M 371329, I/A 21 (19.04.16).
02 de Junio de 2015Nombramientos. VsecrNoConsj: VEGA SORROSAL LUIS. Datos registrales. T 25917 , F 193, S 8, H M 371329, I/A 20 (25.05.15).
22 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ DE SIMON SANTOS GUILLERMO. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZRUIZ ISABEL. Datos registrales. T 25917 , F 192, S 8, H M 371329, I/A 19 (13.03.13).
11 de Marzo de 2013Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25917 , F 192, S 8, H M 371329, I/A 18 ( 1.03.13).
12 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: DUARTE I MACARRO ESTHER. Datos registrales. T 25917 , F 192, S 8, H M 371329, I/A 17 ( 4.02.13).
26 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ RUIZ ISABEL. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTINEZ DE SIMON SANTOSGUILLERMO. Datos registrales. T 25917 , F 191, S 8, H M 371329, I/A 15 (13.10.11).
22 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZRUIZ ISABEL. Datos registrales. T 25917 , F 191, S 8, H M 371329, I/A 14 ( 7.03.11).
17 de Enero de 2011Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25917 , F 191, S 8, H M 371329, I/A 13 ( 5.01.11).
25 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZ MIGUEL;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS;DOMINGUEZSANTOS JULIO;NU脩EZ MORENO FELIX. Datos registrales. T 25917 , F 190, S 8, H M 371329, I/A 12 (12.03.10).
26 de Febrero de 2010Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 8 Y 14 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T25917 , F 190, S 8, H M 371329, I/A 11 (17.02.10).
15 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25917 , F 189, S 8, H M 371329, I/A 10 ( 3.02.10).
04 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO;MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO;NU脩EZ MORENOFELIX. Presidente: FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO. Secretario: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO. Cons.Del.Sol:FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ RUIZ ALEJANDRO;NU脩EZ MORENOFELIX;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. SecreNoConsj: MANZANEDO GONZALEZ FELIX FERNANDO. Consejero: ALDESACONSTRUCCIONES SA. Presidente: ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Cons.Del.Sol: ALDESA CONSTRUCCIONES SA. Consejero:ALDESA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION SL;ALDESA CONCESIONES SL. Datos registrales. T 25917 , F 189, S 8, H M371329, I/A 9 (26.01.10).
16 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apoderado: GOMEZ NAVARRO GONZALO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE FORONDA PEREZMIGUEL;BLANC GARCIA-VALCARCEL CARLOS. Datos registrales. T 25917 , F 187, S 8, H M 371329, I/A 8 ( 3.12.09).
04 de Febrero de 2009Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25917 , F 187, S 8, H M 371329, I/A 7 (23.01.09).