Actos BORME de Aldigavia Oficinas Sl
28 de Julio de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32676 , F 208, S 8, H M 588222,I/A 23 (21.07.23).
23 de Septiembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32676 , F 207, S 8, H M 588222,I/A 22 (16.09.22).
30 de Agosto de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32676 , F 207, S 8, H M 588222,I/A 21 (23.08.21).
18 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32676 , F 207, S 8, H M 588222,I/A 20 (11.11.20).
04 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32676 , F 207, S 8, H M 588222,I/A 19 (25.10.19).
14 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRERO MORENO MARIA ANGELES ASUNCION;DE LA FUENTE SANZ ALBERTO. Datosregistrales. T 32676 , F 205, S 8, H M 588222, I/A 18 ( 7.06.17).
13 de Junio de 2017Nombramientos. Consejero: BARTUREN PANERA ARMANDO. Datos registrales. T 32676 , F 205, S 8, H M 588222, I/A 17 (6.06.17).
18 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE LA FUENTE SANZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: CARPINTERO LOPEZ JUANANTONIO;CARPINTERO GRANDE CARLOS;CARPINTERO GRANDE MARIA;ARCE ALONSO RAUL;CUERVO-ARANGOMARTINEZ CARLOS;MERINO PANADERO FRANCISCO. Presidente: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO. Secretario:DOMINGUEZ SIDERA JUAN-LUIS. Modificaciones estatutarias. Modificci贸n de los art铆culos 2潞, 13潞 y 20潞 de los estatutos sociales.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio de objetosocial. Constituye el objeto social la adquisici贸n de bienes inmuebles de naturaleza urbanapara su arrendamiento. CNAE 6832.Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos que no pueden ser cumplidos por la Sociedad.Datos registrales. T 32676 , F 203, S 8, H M 588222, I/A 16 ( 7.04.17).
26 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 150.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.988.358,50 Euros. Datos registrales. T 32676 , F 202, S8, H M 588222, I/A 14 (18.01.17).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GRUPO ORTIZ PROPERTIES SA. Datos registrales. T 32676 , F203, S 8, H M 588222, I/A 15 (18.01.17).
13 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32676 , F 202, S 8, H M 588222,I/A 13 ( 4.01.17).
22 de Noviembre de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AGRICOLA EL CASAR SL. Datos registrales. T 32676 , F 202, S 8, H M 588222,I/A 12 (11.11.16).
04 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: CARPINTERO GRANDE SARA. Secretario: CARPINTERO GRANDE SARA. Consejero: LANTEROMORENO BRUNO;GARCIA-MURILLO GARCIA JAIME. Presidente: GARCIA-MURILLO GARCIA JAIME. Nombramientos. Adm.Unico: DE LA FUENTE SANZ ALBERTO. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 32676 , F 201, S 8, H M 588222, I/A 11 (26.10.16).
15 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: PARRA HUESO JOSE LUIS. Presidente: PARRA HUESO JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero:GARCIA-MURILLO GARCIA JAIME. Presidente: GARCIA-MURILLO GARCIA JAIME. Datos registrales. T 32676 , F 201, S 8, H M588222, I/A 10 ( 4.12.15).
25 de Febrero de 2015Revocaciones. Apoderado: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO;DOMINGUEZ SIDERA JUAN-LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.:GARCIA MARTIN LORENA MARIA. Datos registrales. T 32676 , F 200, S 8, H M 588222, I/A 9 (18.02.15).
24 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARPINTERO GRANDE SARA. Nombramientos. Consejero: PARRA HUESO JOSE LUIS.Presidente: PARRA HUESO JOSE LUIS. Consejero: CARPINTERO GRANDE SARA. Secretario: CARPINTERO GRANDE SARA.Consejero: LANTERO MORENO BRUNO. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los Art铆culos 10潞.-ACUERDOS y 13潞.-ELORGANO DE ADMINISTRACION.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 32676 , F 57, S 8, H M 588222, I/A 8 (16.02.15).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 32676 , F 57, S 8, H M 588222, I/A 7 (16.02.15).
15 de Enero de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: CASTELLO SOLANO ANDRES;GARCIA MARTIN LORENA MARIA. Datos registrales. T 32676 , F 57, S8, H M 588222, I/A 6 ( 8.01.15).
10 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO LOPEZ ROBERTO. Datos registrales. T 32676 , F 54, S 8, H M 588222, I/A 3(27.11.14).
Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ SIDERA JUAN-LUIS. Datos registrales. T 32676 , F 55, S 8, H M 588222, I/A 4(27.11.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO-JAVIER;DE LA TORRE DIAZ GONZALO. Datos registrales. T 32676 ,F 56, S 8, H M 588222, I/A 5 (27.11.14).
04 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: CARPINTERO LOPEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 32676 , F 52, S 8, H M 588222, I/A 2(27.11.14).
01 de Octubre de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.07.14. Objeto social: las actividades que se expresan a continuaci贸n: la promoci贸n,construcci贸n, comercializaci贸n, tenencia, gesti贸n y explotaci贸n en arrendamiento de locales de negocio de todo tipo. Para ello, podr谩promover y construir edificaciones destinadas al arrendamiento de locales de negocio. Domicilio: AVDA ENSANCHEZ DE VALLECAS