Buscador CIF Logo

Actos BORME Alfa Meldon Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Alfa Meldon Sl

Actos BORME Alfa Meldon Sl - B85563252

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Alfa Meldon Sl con CIF B85563252

馃敊 Perfil de Alfa Meldon Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Alfa Meldon Sl

03 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RIVILLA CALLE BLANCA. Nombramientos. Liquidador: RIVILLA CALLE BLANCA. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 33147 , F 215, S 8, H M 472100, I/A 16 (26.07.16).

09 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GIMENEZ-ARRIBAS GORDILLO LUIS. VsecrNoConsj: TOUBES TORRES PALOMAGUADALUPE. Consejero: RIVILLA CALLE BLANCA. Presidente: RIVILLA CALLE BLANCA. Consejero: GIL GAGO JOSEANTONIO;GUITERAS QUILIS ANDRES. Nombramientos. Adm. Unico: RIVILLA CALLE BLANCA. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 33147 , F 214, S 8, H M 472100,I/A 15 (30.11.15).

20 de Julio de 2015
Revocaciones. Apoderado: MIRETE FERRER PEDRO MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUITERAS QUILIS ANDRES.Datos registrales. T 33147 , F 212, S 8, H M 472100, I/A 14 (10.07.15).

30 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIRETE FERRER PEDRO MANUEL. Nombramientos. Consejero: GUITERAS QUILIS ANDRES.Datos registrales. T 33147 , F 212, S 8, H M 472100, I/A 13 (23.06.15).

12 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO. Secretario: PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO.Revocaciones. Apoderado: PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GIL GAGO JOSE ANTONIO.SecreNoConsj: GIMENEZ-ARRIBAS GORDILLO LUIS. Apoderado: GIL GAGO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 26199 , F 95, S8, H M 472100, I/A 12 (30.04.15).

13 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL. Revocaciones. Apoderado: VILA ABELLAN GARCIAMARIA ISABEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: TOUBES TORRES PALOMA GUADALUPE. Datos registrales. T 26199 , F 95, S8, H M 472100, I/A 11 ( 4.06.13).

18 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SEGURADO GARCIA ALBERTO;SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE. Presidente:SEGURADO GARCIA ALBERTO. Secretario: RIVILLA CALLE BLANCA. Nombramientos. Consejero: PENDAS AGUIRRE ANGELFRANCISCO;MIRETE FERRER PEDRO MANUEL. Presidente: RIVILLA CALLE BLANCA. Secretario: PENDAS AGUIRRE ANGELFRANCISCO. Reelecciones. VsecrNoConsj: VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 26199 , F 92, S 8, H M472100, I/A 9 ( 8.02.13).

Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE;SEGURADO GARCIA ALBERTO;RIVILLA CALLEBLANCA;PENDAS AGUIRRE ANGEL. Nombramientos. Apoderado: RIVILLA CALLE BLANCA;MIRETE FERRER PEDROMANUEL;PENDAS AGUIRRE ANGEL FRANCISCO. Datos registrales. T 26199 , F 93, S 8, H M 472100, I/A 10 (11.02.13).

08 de Agosto de 2011
Nombramientos. Presidente: SEGURADO GARCIA ALBERTO. Secretario: RIVILLA CALLE BLANCA. VsecrNoConsj: VILA ABELLANGARCIA MARIA ISABEL. Apoderado: SANCHEZ DEL VILLAR BOCETA ENRIQUE;SEGURADO GARCIA ALBERTO;RAZQUINMEDINA MARIA JESUS;RIVILLA CALLE BLANCA;GUITERAS QUILIS ANDRES;VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL;PENDASAGUIRRE ANGEL;MARTINEZ SECO NEREA;GARCIA MARTIN BELEN;NAVES GARCIA MARIA JOSE;BAZ CERRO MONTA脩A.Datos registrales. T 26199 , F 89, S 8, H M 472100, I/A 7 (27.07.11).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.994,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.000,00 Euros. Datos registrales. T 26199 , F 91, S 8, H M472100, I/A 8 (27.07.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n