Actos BORME de Algeciras Reefer Port Terminal Sl
06 de Mayo de 2022Cierre provisional hoja registral por baja en el 铆ndice de Entidades Jur铆dicas. Datos registrales. T 2188 , F 89, S 8, H CA 21533,I/A 31 b ( 6.04.22).
12 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ GONZALEZ-MENESES GUILLERMO;RUBIO RIVERA FELIX. Datos registrales. T 2188 ,F 89, S 8, H CA 21533, I/A 30 ( 2.09.16).
Revocaciones. Apoderado: CERVERA GARNICA RAMIRO. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ APARICIO SERGIO. Apoderado: DELGADOPARRA FRANCISCO. Datos registrales. T 2188 , F 89, S 8, H CA 21533, I/A 31 ( 2.09.16).
10 de Diciembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ TENIENTE MAROTO 2 2& (ALGECIRAS). Datos registrales. T 1881 , F 102, S 8, H CA 21533, I/A29 (11.11.14).
30 de Abril de 2013Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MARITIMA DEL ESTRECHO SA. Datos registrales. T 1881 , F 102, S 8, H CA21533, I/A 27 (23.04.13).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 552.550,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.385,00 Euros. Datos registrales. T 1881 , F 102,S 8, H CA 21533, I/A 28 (23.04.13).
13 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: JIMENEZ QUINTERO JOSE MARIA;JIMENEZ QUINTERO JOSE MARIA. Apoderado: SUAREZWACHTER FRANCISCO. Apo.Man.Soli: MARCHANTE RIVERA FRANCISCO JAVIER;DELGADO PARRA FRANCISCO;DELGADOPARRA FRANCISCO. Datos registrales. T 1881 , F 101, S 8, H CA 21533, I/A 26 ( 4.09.12).
04 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: DELGADO PARRA FRANCISCO. Datos registrales. T 1881 , F 101, S 8, H CA 21533, I/A 25(21.03.12).
26 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: CABEZA RIVAS FRANCISCO. Presidente: CABEZA RIVAS FRANCISCO. Con.Delegado: CABEZARIVAS FRANCISCO. Consejero: MORENO BRIBIAN IGNACIO;JIMENEZ QUINTERO JOSE MARIA. Con.Delegado: JIMENEZQUINTERO JOSE MARIA. Secretario: FRAILE BARTOLOME GREGORIO. Nombramientos. Adm. Unico: MARITIMA DELESTRECHO SA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador煤nico. Datos registrales. T 1881 , F 100, S 8, H CA 21533, I/A 24 (14.09.11).
09 de Mayo de 2011Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.174.050,00 Euros. ResultanteSuscrito: 560.935,00 Euros. Datos registrales. T 1881 , F 100, S 8, H CA 21533, I/A 23 (26.04.11).
13 de Agosto de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: DELGADO PARRA FRANCISCO;RODRIGUEZ APARICIO SERGIO. Datos registrales. T 1881 , F99, S 8, H CA 21533, I/A 22 ( 4.08.09).
25 de Junio de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: RAMOS ALFONSO LUIS FEDERICO. Nombramientos. Apoderado: CERVERA GARNICA RAMIRO.Con.Delegado: CABEZA RIVAS FRANCISCO. Datos registrales. T 1881 , F 98, S 8, H CA 21533, I/A 21 ( 9.06.09).