Actos BORME de Algry Quimica Sl
30 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO JENTOFT ENRIQUE. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO JENTOFT ENRIQUE.Datos registrales. T 760 , F 225, S 8, H H 8624, I/A 73 (17.03.23).
18 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 225, S 8, H H 8624, I/A 72 (3.11.22).
19 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO HERRERA MARIA. Nombramientos. Consejero: ALONSO HERRERA TERESA. Datosregistrales. T 760 , F 223, S 8, H H 8624, I/A 69 ( 3.10.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA MARIA. Datos registrales. T 760 , F 223, S 8, H H 8624, I/A 70 ( 3.10.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA TERESA. Datos registrales. T 760 , F 223, S 8, H H 8624, I/A 71 ( 3.10.22).
22 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 223, S 8, H H 8624, I/A 68(11.02.22).
06 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: RICO FEIJOO MARIA LUISA. Datos registrales. T 760 , F 222, S 8, H H 8624, I/A 67 (15.04.21).
14 de Abril de 2021Nombramientos. Vicepresid.: ALONSO DE DIEGO MARIA. Vicesecret.: GAITE ALONSO MYRIAM. Datos registrales. T 760 , F222, S 8, H H 8624, I/A 66 ( 6.04.21).
24 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 222, S 8, H H 8624, I/A 65(11.02.21).
22 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Presidente: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Revocaciones.Apo.Man.Soli: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Nombramientos. Presidente: ALONSO JENTOFT CARLOS. Datos registrales. T760 , F 221, S 8, H H 8624, I/A 64 (31.12.20).
24 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: GAITE ALONSO MYRIAM. Datos registrales. T 760 , F 220, S 8, H H 8624, I/A 63 (27.11.20).
01 de Julio de 2020Nombramientos. Consejero: GAITE ALONSO MYRIAM. Datos registrales. T 760 , F 219, S 8, H H 8624, I/A 62 ( 4.06.20).
03 de Abril de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 219, S 8, H H 8624, I/A 61(20.03.20).
17 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA ENRIQUE. Datos registrales. T 760 , F 217, S 8, H H 8624, I/A 60 ( 4.03.20).
06 de Noviembre de 2019Nombramientos. Consejero: ALONSO HERRERA ENRIQUE. Datos registrales. T 760 , F 217, S 8, H H 8624, I/A 59 (24.10.19).
12 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO JENTOFT JOSE LUIS. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO JENTOFT JOSE LUIS.Datos registrales. T 760 , F 217, S 8, H H 8624, I/A 58 (25.02.19).
26 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA TERESA. Apo.Sol.: MARTIN HINOJAR SANDRA. Nombramientos. Apoderado:VALERA ALONSO JAVIER. Datos registrales. T 760 , F 215, S 8, H H 8624, I/A 56 ( 7.11.18).
Nombramientos. Consejero: VARELA ALONSO JAVIER. Datos registrales. T 760 , F 217, S 8, H H 8624, I/A 57 ( 7.11.18).
04 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: GAITE ALONSO EDUARDO. Nombramientos. Consejero: GAITE ALONSO JAVIER;ALONSOPEDREGAL IGNACIO;ALIQUE ALONSO CRISTINA. Secretario: ALIQUE ALONSO CRISTINA. Datos registrales. T 760 , F 214, S 8,H H 8624, I/A 55 (22.08.17).
25 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: GAITE ALONSO JAVIER;ALIQUE ALONSO CRISTINA. Apo.Sol.: GAITE ALONSO JAVIER.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALIQUE ALONSO CRISTINA;GAITE ALONSO JAVIER;ALONSO PEDREGAL IGNACIO. Datosregistrales. T 760 , F 212, S 8, H H 8624, I/A 54 (15.05.17).
25 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO AVENTIN ANTONIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO AVENTIN ANTONIO.Apoderado: FERNANDEZ GALLEGO ANTONIO. Apo.Sol.: FERNANDEZ GALLEGO ANTONIO. Datos registrales. T 760 , F 211, S 8,H H 8624, I/A 51 ( 3.08.16).
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 212, S 8, H H 8624, I/A52 ( 3.08.16).
Nombramientos. Consejero: ALONSO HERRERA MARIA. Datos registrales. T 760 , F 212, S 8, H H 8624, I/A 53 ( 3.08.16).
26 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA MARIA. Datos registrales. T 760 , F 210, S 8, H H 8624, I/A 50 ( 4.05.16).
23 de Septiembre de 2015Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 209, S 8, H H 8624, I/A 49 (11.09.15).
26 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: ALONSO JENTOFT JOSE LUIS. Secretario: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Revocaciones.Apo.Manc.: MEDRANO GARCIA MARIA DEL CARMEN. Apo.Sol.: MEDRANO GARCIA MARIA DEL CARMEN. Nombramientos.Presidente: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Secretario: GAITE ALONSO EDUARDO. Datos registrales. T 760 , F 209, S 8, H H 8624,I/A 48 (13.03.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAPITAN LOPEZ SIMON. Apo.Sol.:VALERO GUTIERREZ DEL OLMO PABLO. Apo.Man.Soli: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Datos registrales. T 760 , F 209, S 8, H H
01 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 208, S 8, H H 8624, I/A 46 (16.09.14).
17 de Septiembre de 2014Otros conceptos: - Nota Marginal de Incentivos Regionales para la Referencia H/438/P08 concedida en la entrada 1/2014/2411,0 confecha de aceptaci贸n 31/07/2014. Datos registrales. T 760 , F 205, S 8, H H 8624, I/A 45 N ( 3.09.14).
08 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA TERESA.Datos registrales. T 760 , F 205, S 8, H H 8624, I/A 45 (23.04.14).
31 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 204, S 8, H H 8624,H , I/ 42 .(24.10.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: GAITE ALONSO JAVIER. Datos registrales. T 760 , F 204, S 8, H H 8624,H , I/ 43 .(24.10.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GALLEGO ANTONIO. Datos registrales. T 760 , F 205, S 8, H H 8624,H , I/ 44.(24.10.13).
13 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: LAMIGUEIRO PEREA MIGUEL. Apo.Sol.: MORENCOS RUIZ-JARABO PILAR. Nombramientos.Apo.Man.Soli: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ;ALIQUE ALONSO CRISTINA;ALONSO HERRERA ENRIQUE. Datos registrales. T 760, F 199, S 8, H H 8624,H , I/ 41 .( 1.02.13).
19 de Diciembre de 2012Nombramientos. Consejero: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Datos registrales. T 760 , F 198, S 8, H H 8624,H , I/ 40 .(28.11.12).
24 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 198, S 8, H H 8624,H , I/ 39 .(14.09.12).
06 de Septiembre de 2011Nombramientos. Consejero: GAITE ALONSO EDUARDO. Datos registrales. T 760 , F 198, S 8, H H 8624,H , I/ 38 .(23.08.11).
27 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO DE DIEGO MARIA;GAITE ALONSO EDUARDO. Datos registrales. T 760 , F 193, S 8, HH 8624,H , I/ 34 .(14.06.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO AVENTIN MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: ALONSO AVENTIN MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 760 , F 196, S 8, H H 8624,H , I/ 35 .(14.06.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: VALERO GUTIERREZ DEL OLMO PABLO;MORENCOS RUIZ-JARABO PILAR;MARTIN HINOJARSANDRA Datos registrales. T 760 , F 196, S 8, H H 8624,H , I/ 36 .(14.06.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO AVENTIN MIGUEL ANGEL;ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Datos registrales. T 760 , F198, S 8, H H 8624,H , I/ 37 .(14.06.11).
16 de Marzo de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ZARZOSA MONICA. Nombramientos. Apoderado: MARUGAN PEREZ MONTSERRAT.Datos registrales. T 760 , F 190, S 8, H H 8624,H , I/ 32 .(23.02.10).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Nombramientos. Consejero: ALONSO DE DIEGO MARIA. Datosregistrales. T 760 , F 193, S 8, H H 8624,H , I/ 33 .(23.02.10).
23 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 760 , F 190, S 8, H H 8624,H , I/ 31 .( 6.11.09).
06 de Marzo de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: NIEVAS ANDRES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 760 , F 190, S 8, H H 8624,H , I/ 30.(25.02.09).
23 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GALLEGO ANTONIO. Datos registrales. T 760 , F 187, S 8, H H 8624,H , I/ 29.(22.12.08).