Actos BORME de Algupibe Sl
24 de Agosto de 2023Ampliacion del objeto social. "El alquiler de autom贸viles sin conductor" y "el mantenimiento y gesti贸n de flotas de veh铆culos". Datosregistrales. T 4453, L 4453, F 25, S 8, H PO 12585, I/A 27 (17.08.23).
11 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PEREZ NIETO JOSE RAMON. Datos registrales. T 4453, L 4453, F 25, S 8, H PO 12585, I/A 26 (3.08.23).
23 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: CASTRO RODRIGUEZ OLAYA. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 225, S 8, H PO 12585, I/A 24(15.02.23).
19 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 225, S 8, H PO 12585, I/A 23 (10.01.22).
07 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: VEIGA GONZALEZ DAVID. Apo.Manc.: FIEL CAI脩O JOSE MANUEL;MARI脩O RUIZ CONSUELO;CASTRORODRIGUEZ OLALLA. Apo.Sol.: FIEL CAI脩O JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 225, S 8, H PO 12585, I/A 22(30.05.19).
10 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: GOMEZ OTERO DAVID. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 225, S 8, H PO 12585, I/A 21(29.11.18).
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 224, S 8, H PO 12585, I/A 20 (29.11.18).
19 de Junio de 2018Cambio de domicilio social. CTRA DE MADRID 152 (VIGO). Datos registrales. T 2872, L 2872, F 224, S 8, H PO 12585, I/A 19(12.06.18).
13 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ ALONSO JOSE CARLOS. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 224, S 8, H PO 12585, I/A 18(30.10.12).
17 de Noviembre de 2011Cambio de domicilio social. CTRA CARRETERA DE CAMPOSANCOS 107 (VIGO). Datos registrales. T 2872, L 2872, F 224, S 8,H PO 12585, I/A 17 ( 4.11.11).
18 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: VEIGA GONZALEZ DAVID;ALVAREZ ALONSO JOSE CARLOS. Datos registrales. T 2872, L 2872, F224, S 8, H PO 12585, I/A 16 ( 8.11.10).
06 de Septiembre de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: VILLAVERDE ABALO ALVARO;SASTRE AROS SANTIAGO. Apo.Sol.: VILLAVERDE ABALOALVARO;SASTRE AROS SANTIAGO. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 223, S 8, H PO 12585, I/A 14 (24.08.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: SASTRE AROS SANTIAGO. Apo.Manc.: FIEL CAI脩O JOSE MANUEL;MARI脩O RUIZCONSUELO;CASTRO RODRIGUEZ OLALLA. Apo.Sol.: FIEL CAI脩O JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 223, S 8,H PO 12585, I/A 15 (24.08.10).
18 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ ALONSO BENIGNO. Nombramientos. Adm. Solid.: PEREZ NIETO JOSE RAMON.Datos registrales. T 2872, L 2872, F 223, S 8, H PO 12585, I/A 13 ( 5.05.10).
04 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: SASTRE AROS SANTIAGO;VILLAVERDE ABALO ALVARO. Apo.Sol.: SASTRE AROSSANTIAGO;VILLAVERDE ABALO ALVARO. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 223, S 8, H PO 12585, I/A 12 (22.10.09).
17 de Junio de 2009Nombramientos. Adm. Solid.: SEIJAS PEREZ RAMON MARIA. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 11潞.- Los 贸rganos de laSociedad son: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y TRES ADMINISTRADORES SOLIDARIOS.. ARTICULO 16潞.- La Administraci贸nde la Sociedad y su representaci贸nen juicio y fuera de 茅l corresponde a TRES ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, quienes podr谩nhacer y llevar a cabo cuento est茅. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 223, S 8, H PO 12585, I/A 11 ( 4.06.09).
07 de Mayo de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 729.914,50 Euros. Resultante Suscrito: 741.934,50 Euros. Datos registrales. T 2872, L 2872, F 222,S 8, H PO 12585, I/A 10 (24.04.09).