Buscador CIF Logo

Actos BORME Aliberinox Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Aliberinox Sl

Actos BORME Aliberinox Sl - B82833807

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Aliberinox Sl con CIF B82833807

馃敊 Perfil de Aliberinox Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Aliberinox Sl

17 de Enero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ DE BERLIN 12 (TORRES DE LA ALAMEDA). Datos registrales. T 30324 , F 202, S 8, H M 275323,I/A 22 (10.01.18).

12 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARZAGHI GRAZIELLA. Presidente: SASSOLI ANDREA. Consejero: SASSOLI ANDREA.Cons.Del.Sol: SASSOLI ANDREA. Consejero: GIANFRANCO ANGELO. Nombramientos. Adm. Unico: SASSOLI ANDREA. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 30324 , F202, S 8, H M 275323, I/A 21 ( 5.01.18).

17 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Datos registrales. T 30324 , F 202, S 8, H M 275323,I/A 20 ( 6.04.17).

20 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SASSOLI GIANNANDREA. Secretario: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. VsecrNoConsj:MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Revocaciones. Apoderado: GARCIA RODRIGUEZ BORIS LUIS. Nombramientos.Consejero: BARZAGHI GRAZIELLA. SecreNoConsj: MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Reelecciones. Presidente: SASSOLIANDREA. Consejero: SASSOLI ANDREA. Cons.Del.Sol: SASSOLI ANDREA. Consejero: GIANFRANCO ANGELO. Datosregistrales. T 30324 , F 201, S 8, H M 275323, I/A 19 ( 9.04.15).

26 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: SASSOLI GIULIANO. Consejero: GALBIATI ANDREA;SASSOLI GIULIANO. Cons.Del.Sol: SASSOLIGIULIANO. Consejero: ALBERTONI MARCO LUCA. Nombramientos. Consejero: GIANFRANCO ANGELO. Datos registrales. T30324 , F 200, S 8, H M 275323, I/A 18 (18.12.13).

01 de Julio de 2013
Revocaciones. Apoderado: GARCIA FERNANDEZ DAVID;GARCIA RODRIGUEZ BORIS LUIS;MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA.Nombramientos. VsecrNoConsj: MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Apoderado: GARCIA RODRIGUEZ BORISLUIS;MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Datos registrales. T 30324 , F 200, S 8, H M 275323, I/A 17 (21.06.13).

17 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: NU脩EZ PALOMAR JUAN JOSE;RAMIREZ MU脩OZ LUIS MIGUEL. Nombramientos. Apoderado:GARCIA FERNANDEZ DAVID;GARCIA RODRIGUEZ BORIS LUIS;MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 16228 ,F 182, S 8, H M 275323, I/A 16 ( 9.01.13).

16 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARNIO DIEGO. Datos registrales. T 16228 , F 182, S 8, H M 275323, I/A 14 ( 4.01.13).

Cambio de domicilio social. CMNO DEL OLIVAR 21 (ALCALA DE HENARES). Datos registrales. T 16228 , F 182, S 8, H M275323, I/A 15 ( 4.01.13).

22 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Secretario: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Presidente: SASSOLI ANDREA. Vicepresid.: SASSOLI GIULIANO.Consejero: GALBIATI ANDREA;SASSOLI GIULIANO;SASSOLI GIANNANDREA;SASSOLI ANDREA. Cons.Del.Sol: SASSOLIGIULIANO;SASSOLI ANDREA. Consejero: ALBERTONI MARCO LUCA;CARNIO DIEGO. Datos registrales. T 16228 , F 181, S 8, H

08 de Abril de 2009
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MAYO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ PALOMAR JUANJOSE;RAMIREZ MU脩OZ LUIS MIGUEL;MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 16228 , F 181, S 8, H M 275323,I/A 12 (26.03.09).

06 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MAYO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 16228 , F 180, S 8, H M 275323, I/A 11(25.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n