Actos BORME de Aliberinox Sl
17 de Enero de 2018Cambio de domicilio social. C/ DE BERLIN 12 (TORRES DE LA ALAMEDA). Datos registrales. T 30324 , F 202, S 8, H M 275323,I/A 22 (10.01.18).
12 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BARZAGHI GRAZIELLA. Presidente: SASSOLI ANDREA. Consejero: SASSOLI ANDREA.Cons.Del.Sol: SASSOLI ANDREA. Consejero: GIANFRANCO ANGELO. Nombramientos. Adm. Unico: SASSOLI ANDREA. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 30324 , F202, S 8, H M 275323, I/A 21 ( 5.01.18).
17 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Datos registrales. T 30324 , F 202, S 8, H M 275323,I/A 20 ( 6.04.17).
20 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SASSOLI GIANNANDREA. Secretario: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. VsecrNoConsj:MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Revocaciones. Apoderado: GARCIA RODRIGUEZ BORIS LUIS. Nombramientos.Consejero: BARZAGHI GRAZIELLA. SecreNoConsj: MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Reelecciones. Presidente: SASSOLIANDREA. Consejero: SASSOLI ANDREA. Cons.Del.Sol: SASSOLI ANDREA. Consejero: GIANFRANCO ANGELO. Datosregistrales. T 30324 , F 201, S 8, H M 275323, I/A 19 ( 9.04.15).
26 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: SASSOLI GIULIANO. Consejero: GALBIATI ANDREA;SASSOLI GIULIANO. Cons.Del.Sol: SASSOLIGIULIANO. Consejero: ALBERTONI MARCO LUCA. Nombramientos. Consejero: GIANFRANCO ANGELO. Datos registrales. T30324 , F 200, S 8, H M 275323, I/A 18 (18.12.13).
01 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: GARCIA FERNANDEZ DAVID;GARCIA RODRIGUEZ BORIS LUIS;MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA.Nombramientos. VsecrNoConsj: MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Apoderado: GARCIA RODRIGUEZ BORISLUIS;MARTINEZ DE LECEA GARCIA EMILIO. Datos registrales. T 30324 , F 200, S 8, H M 275323, I/A 17 (21.06.13).
17 de Enero de 2013Revocaciones. Apoderado: NU脩EZ PALOMAR JUAN JOSE;RAMIREZ MU脩OZ LUIS MIGUEL. Nombramientos. Apoderado:GARCIA FERNANDEZ DAVID;GARCIA RODRIGUEZ BORIS LUIS;MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 16228 ,F 182, S 8, H M 275323, I/A 16 ( 9.01.13).
16 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CARNIO DIEGO. Datos registrales. T 16228 , F 182, S 8, H M 275323, I/A 14 ( 4.01.13).
Cambio de domicilio social. CMNO DEL OLIVAR 21 (ALCALA DE HENARES). Datos registrales. T 16228 , F 182, S 8, H M275323, I/A 15 ( 4.01.13).
22 de Noviembre de 2010Reelecciones. Secretario: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Presidente: SASSOLI ANDREA. Vicepresid.: SASSOLI GIULIANO.Consejero: GALBIATI ANDREA;SASSOLI GIULIANO;SASSOLI GIANNANDREA;SASSOLI ANDREA. Cons.Del.Sol: SASSOLIGIULIANO;SASSOLI ANDREA. Consejero: ALBERTONI MARCO LUCA;CARNIO DIEGO. Datos registrales. T 16228 , F 181, S 8, H
08 de Abril de 2009Revocaciones. Apoderado: GARCIA MAYO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ PALOMAR JUANJOSE;RAMIREZ MU脩OZ LUIS MIGUEL;MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 16228 , F 181, S 8, H M 275323,I/A 12 (26.03.09).
06 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MAYO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 16228 , F 180, S 8, H M 275323, I/A 11(25.03.09).