Actos BORME de Alicantina De Construccion Y Edificios Sociedad Anonima
15 de Marzo de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 25.306,16 Euros. Desembolsado: 25.306,16 Euros. Resultante Suscrito: 630.353,12 Euros.Resultante Desembolsado: 630.353,12 Euros. Datos registrales. T 4234 , F 13, S 8, H A 2892, I/A 68 ( 8.03.22).
02 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ ARQUES PABLO. Datos registrales. T 4234 , F 12, S 8, H A 2892, I/A 67 (22.11.19).
28 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: HERNANDEZ ARQUES PABLO;COMPANY BARAHONA MARIA ISABEL. Apoderado: HERNANDEZARQUES PABLO;HERNANDEZ ARQUES PABLO;SIRVENT GALIANA VICTOR ALEJANDRO. Datos registrales. T 4234 , F 12, S 8,H A 2892, I/A 66 (20.11.19).
03 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 4234 , F 11, S 8, H A 2892, I/A 65 (25.09.19).
20 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SIRVENT PERAL JOSE FELIPE;PLANELLES DONAT MARIA OTILIA;SIRVENT GALIANA VICTORALEJANDRO. Presidente: RODENAS GUILLEN ANGEL FEDERICO. Con.Delegado: RODENAS GUILLEN ANGEL FEDERICO.Vicepresid.: SIRVENT GALIANA VICTOR ALEJANDRO. SecreNoConsj: LOPEZ MARTINEZ-ACACIO PRUDENCIO. VsecrNoConsj:HERNANDEZ MORATO ALEXANDRA. Nombramientos. Consejero: VIDAL VIDAL JESUS;SIRVENT JORNET JORGE. Presidente:VIDAL RUZ RAUL. Vicepresid.: VIDAL VIDAL JESUS. Con.Delegado: VIDAL RUZ RAUL. SecreNoConsj: HERNANDEZ ARQUESPABLO. Reelecciones. Consejero: VIDAL RUZ RAUL;RODENAS GUILLEN ANGEL FEDERICO. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 22.. CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 4234 , F 11, S 8, H A 2892, I/A 64 (12.09.19).
02 de Agosto de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 439.798,24 Euros. Desembolsado: 439.798,24 Euros. Resultante Suscrito: 605.046,96 Euros.Resultante Desembolsado: 605.046,96 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 13潞. DERECHO DE ASISTENCIA.. Datosregistrales. T 3758 , F 26, S 8, H A 2892, I/A 63 (26.07.19).
06 de Marzo de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.478.730,80 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:165.248,72 Euros. Desembolsado: 165.248,72 Euros. Resultante Suscrito: 165.248,72 Euros. Resultante Desembolsado: 165.248,72Euros. Otros conceptos: Modificados la totalidad de los estatutos sociales.- Datos registrales. T 3758 , F 26, S 8, H A 2892, I/A 62(26.02.19).
20 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 3758 , F 25, S 8, H A 2892, I/A 61 ( 9.08.18).
28 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 3758 , F 25, S 8, H A 2892, I/A 60 (21.09.17).
27 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GARCIA PALOP SANDRA. Consejero: VIDAL VIDAL JESUS. Nombramientos. VsecrNoConsj:HERNANDEZ MORATO ALEXANDRA. Consejero: VIDAL RUZ RAUL. Datos registrales. T 3758 , F 25, S 8, H A 2892, I/A 59(18.09.17).
24 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLS TRIVES VICENTE LAZARO. Datos registrales. T 3758 , F 25, S 8, H A 2892, I/A 58(16.05.17).
17 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VALLS TRIVES JOSE MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZ MARTINEZ-ACACIOPRUDENCIO. VsecrNoConsj: GARCIA PALOP SANDRA. Datos registrales. T 3758 , F 25, S 8, H A 2892, I/A 57 ( 5.04.17).
31 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 3758 , F 25, S 8, H A 2892, I/A 56 (23.08.16).
10 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: VIDAL VIDAL JESUS. Con.Delegado: VIDAL VIDAL JESUS. Vicepresid.: RODENAS GUILLENANGEL FEDERICO. Nombramientos. Presidente: RODENAS GUILLEN ANGEL FEDERICO. Con.Delegado: RODENAS GUILLENANGEL FEDERICO. Vicepresid.: SIRVENT GALIANA VICTOR ALEJANDRO. Datos registrales. T 3758 , F 24, S 8, H A 2892, I/A 55 (2.06.16).
05 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 3758 , F 24, S 8, H A 2892, I/A 54 (28.09.15).
21 de Agosto de 2015Cambio de domicilio social. AVDA MAISONNAVE 18 6 4 (ALICANTE). Datos registrales. T 3758 , F 24, S 8, H A 2892, I/A 53(13.08.15).
18 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 3758 , F 24, S 8, H A 2892, I/A 52 ( 7.08.14).
11 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VIDAL VIDAL JESUS. Nombramientos. Con.Delegado: VIDAL VIDAL JESUS. Reelecciones.Consejero: RODENAS GUILLEN ANGEL FEDERICO;VALLS TRIVES VICENTE LAZARO;SIRVENT PERAL JOSE FELIPE;SIRVENTGALIANA VICTOR ALEJANDRO;VIDAL VIDAL JESUS. Presidente: VIDAL VIDAL JESUS. Vicepresid.: RODENAS GUILLEN ANGELFEDERICO. Consejero: PLANELLES DONAT MARIA OTILIA. Secretario: VALLS TRIVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 3758 ,F 24, S 8, H A 2892, I/A 51 ( 1.08.14).
17 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: SIRVENT GALIANA VICTOR ALEJANDRO. Datos registrales. T 2275 , F 222, S 8, H A 2892, I/A 50 (7.03.14).
08 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 2275 , F 222, S 8, H A 2892, I/A 49 (30.09.13).
18 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 2275 , F 221, S 8, H A 2892, I/A 48 ( 7.02.13).
24 de Mayo de 2012Nombramientos. Auditor: ULLOA GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 2275 , F 221, S 8, H A 2892, I/A 47 (14.05.12).
17 de Abril de 2012Nombramientos. Consejero: PLANELLES DONAT MARIA OTILIA. Datos registrales. T 2275 , F 221, S 8, H A 2892, I/A 46 (3.04.12).
13 de Abril de 2012Nombramientos. Presidente: VIDAL VIDAL JESUS. Vicepresid.: RODENAS GUILLEN ANGEL FEDERICO. Datos registrales. T2275 , F 221, S 8, H A 2892, I/A 45 (30.03.12).
11 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MIRA DOMENECH ENRIQUE. Presidente: VIDAL VIDAL JESUS. Datos registrales. T 2275 , F 144,S 8, H A 2892, I/A 44 (28.03.12).
03 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MIRA DOMENECH ENRIQUE. Consejero: MIRA DOMENECH ENRIQUE. Vicepresid.: MIRADOMENECH ENRIQUE. Cons.Del.Sol: MIRA DOMENECH ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: MIRA DOMENECH ENRIQUE.Cons.Del.Sol: MIRA DOMENECH ENRIQUE. Datos registrales. T 2275 , F 144, S 8, H A 2892, I/A 43 (21.07.11).
07 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ ARQUES PABLO. Datos registrales. T 2275 , F 144, S 8, H A 2892, I/A 41 (25.11.09).
24 de Septiembre de 2009Revocaciones. Apoderado: SEGUI ROMA JORGE. Datos registrales. T 2275 , F 144, S 8, H A 2892, I/A 40 (14.09.09).
23 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ ARQUES PABLO. Datos registrales. T 2275 , F 143, S 8, H A 2892, I/A 39 (11.09.09).
22 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MIRA DOMENECH ENRIQUE;VIDAL VIDAL JESUS. Nombramientos. Cons.Del.Sol: VIDALVIDAL JESUS;MIRA DOMENECH ENRIQUE. Reelecciones. Secretario: VALLS TRIVES JOSE MARIA. Consejero: RODENASGUILLEN ANGEL FEDERICO;MIRA DOMENECH ENRIQUE. Vicepresid.: MIRA DOMENECH ENRIQUE. Consejero: VALLS TRIVESVICENTE LAZARO;SIRVENT PERAL JOSE FELIPE;SIRVENT GALIANA VICTOR ALEJANDRO;VIDAL VIDAL JESUS. Presidente:VIDAL VIDAL JESUS. Datos registrales. T 2275 , F 143, S 8, H A 2892, I/A 38 (10.09.09).