Actos BORME de Alimentacion Varma Sl
28 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: DE LOS BUEIS ALONSO ALBERTO;ALONSO RUANO ENRIQUE;PEREZ PUMARESRAFAEL;FERNANDEZ LUJAN MARIA DE LA PAZ. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ LUJAN MARIA DE LA PAZ;DELOS BUEIS ALONSO ALBERTO;FERNANDEZ SANGUINO LUCIA;PEREZ PUMARES RAFAEL. Datos registrales. T 34020 , F 187,S 8, H M 122014, I/A 55 (21.11.23).
03 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: DE LOS BUEIS ALONSO ALBERTO;ALONSO RUANO ENRIQUE;PEREZ PUMARES RAFAEL.Nombramientos. Apoderado: DE LOS BUEIS ALONSO ALBERTO;ALONSO RUANO ENRIQUE;PEREZ PUMARESRAFAEL;FERNANDEZ QUIROGA CARLOS;FERNANDEZ LUJAN MARIA DE LA PAZ. Datos registrales. T 34020 , F 186, S 8, H M122014, I/A 54 (24.02.23).
11 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: REY LIEBANA JUAN MANUEL. Apo.Manc.: REY LIEBANA JUAN MANUEL;SANCHEZ-CESPEDESMIELGO RODRIGO. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ARRECHEA MIGUEL;SANCHEZ-CESPEDES MIELGO RODRIGO.Datos registrales. T 34020 , F 185, S 8, H M 122014, I/A 53 ( 4.10.22).
27 de Mayo de 2022Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 34020 , F 185, S 8, H M 122014, I/A 52 (20.05.22).
07 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 34020 , F 185, S 8, H M 122014, I/A 51 (30.09.21).
14 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ QUIROGA CARLOS. Datos registrales. T 34020 , F 184, S 8, H M 122014, I/A 50 (7.09.21).
07 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: GIL CASARES Y ARMADA ALVARO. Datos registrales. T 34020 , F 182, S 8, H M 122014, I/A 47(31.08.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN DE LA MATA TERESA;POSADA DE LA MATA JESUS;DE LA MATA ROMERO JOSEMANUEL. Datos registrales. T 34020 , F 182, S 8, H M 122014, I/A 48 (31.08.21).
Nombramientos. Apoderado: MATEOS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34020 , F 184, S 8, H M 122014, I/A49 (31.08.21).
17 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: GESTION Y ASESORIA OCON SL. Nombramientos. Presidente: MARTIN DE LA MATA MARIATERESA. Datos registrales. T 34020 , F 182, S 8, H M 122014, I/A 46 (10.08.21).
16 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA MATA POBES JOSE MANUEL. Vicepresid.: DE LA MATA POBES JOSE MANUEL.Nombramientos. Consejero: DE LA MATA ROMERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 34020 , F 182, S 8, H M 122014, I/A 45 (9.08.21).
16 de Junio de 2021Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 34020 , F 181, S 8, H M 122014, I/A 44 ( 9.06.21).
10 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ-CESPEDES MIELGO RODRIGO. Datos registrales. T 34020 , F 181, S 8, H M 122014, I/A43 ( 3.03.21).
16 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ VIVAS MARIANO. Nombramientos. Apo.Manc.: REY LIEBANA JUAN MANUEL;SANCHEZ-CESPEDES MIELGO RODRIGO. Datos registrales. T 34020 , F 180, S 8, H M 122014, I/A 42 ( 9.02.21).
09 de Diciembre de 2020Otros conceptos: RECTIFICACION DEL NOMBRAMIENTO DE CARGOS ADOPTADO POR EL SOCIO UNICO EL 1 DE JULIO DE
03 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: AUDALIA NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 34020 , F 180, S 8, H M 122014, I/A 40 (27.01.20).
01 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL CASARES Y ARMADA ALVARO. Con.Delegado: GIL CASARES Y ARMADA ALVARO. Datosregistrales. T 34020 , F 179, S 8, H M 122014, I/A 38 (25.01.19).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MANJON JUAN BAUTISTA. Nombramientos. Apoderado: REY LIEBANA JUANMANUEL;DE LOS BUEIS ALONSO ALBERTO;ALONSO RUANO ENRIQUE;PEREZ PUMARES RAFAEL. Datos registrales. T 34020, F 179, S 8, H M 122014, I/A 39 (26.01.19).
03 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ VIVAS MARIANO. Datos registrales. T 34020 , F 178, S 8, H M 122014, I/A 37 (26.06.18).
13 de Mayo de 2016Reelecciones. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 34020 , F 178, S 8, H M 122014, I/A 36 ( 6.05.16).
02 de Febrero de 2016Modificaciones estatutarias. NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Ampliacion del objeto social. 1.Constituye el objeto social de la Sociedad la comercializaci贸n, representaci贸n, distribuci贸n, importaci贸n, exportaci贸n, envasado y
26 de Marzo de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:350.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 350.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 100.000,00 Euros. ResultanteSuscrito: 250.000,00 Euros. Datos registrales. T 19259 , F 178, S 8, H M 122014, I/A 34 (16.03.15).
03 de Junio de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 559.999,78 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.000,00 Euros. Datos registrales. T 19259 , F 177, S 8, H M 122014, I/A 33 (24.05.13).
07 de Mayo de 2013Reelecciones. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 19259 , F 177, S 8, H M 122014, I/A 32 (25.04.13).
29 de Abril de 2010Reelecciones. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 19259 , F 177, S 8, H M 122014, I/A 31 (20.04.10).
04 de Enero de 2010Cambio de domicilio social. C/ LA GRANJA 15 - POLIGONO INDUSTRIAL DE ALCOBENDA (ALCOBENDAS). Datos registrales.T 19259 , F 177, S 8, H M 122014, I/A 30 (21.12.09).
06 de Abril de 2009Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SNACK FOODS SL. Datos registrales. T 19259 , F 175, S 8, H M 122014, I/A 29(25.03.09).
03 de Abril de 2009Reelecciones. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 19259 , F 175, S 8, H M 122014, I/A 28 (24.03.09).