Actos BORME de Alkenencia Sicav Sa
13 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apoderado: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC;MARTINEZ MOSCARDO RAFAEL;RAMIREZ-MONSONIS ANGLIKER ANA;BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA;BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC;BBVA ASSETMANAGEMENT SA SGIIC. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 29陋 revocar todos los poderes de la sociedad. Datosregistrales. T 28523 , F 146, S 8, H M 288363, I/A 29 (23.08.22).
30 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MOSCARDO BENJAMIN;MARTINEZ MOSCARDO FRANCISCO GONZALO. Presidente:MARTINEZ MOSCARDO RAFAEL. Consejero: MARTINEZ MOSCARDO RAFAEL. Secretario: MARTINEZ MOSCARDO FRANCISCOGONZALO. VsecrNoConsj: DE LA PE脩A FERNANDEZ-NESPRAL LUIS. EntidDeposit: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.Ent. Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC. Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Liquidador:MARTINEZ LLINARES GUILLERMO. Otros conceptos: Se revoca la designaci贸n de Iberclear como entidad encargada de lallevanza del Registro contable de las acciones. Y queda excluida de cotizacion de las acciones en BME MTF Equity (BME),renunciando a la autorizaci贸n administrativa concedida por la CNMV. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 28523, F 146, S 8, H M 288363, I/A 29 (23.08.22).
28 de Septiembre de 2021Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MOSCARDO BENJAMIN;MARTINEZ MOSCARDO FRANCISCO GONZALO. Presidente:MARTINEZ MOSCARDO RAFAEL. Consejero: MARTINEZ MOSCARDO RAFAEL. Secretario: MARTINEZ MOSCARDO FRANCISCOGONZALO. Datos registrales. T 28523 , F 145, S 8, H M 288363, I/A 28 (21.09.21).
25 de Noviembre de 2020Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28523 , F 145, S 8, H M 288363, I/A 27 (18.11.20).
29 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: LOUREIRO BOTANA CONCEPCION. Nombramientos. VsecrNoConsj: DE LA PE脩AFERNANDEZ-NESPRAL LUIS. Datos registrales. T 28523 , F 145, S 8, H M 288363, I/A 26 (19.07.19).
21 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28523 , F 145, S 8, H M 288363, I/A 25 (13.09.17).
09 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. EntidDeposit: BANCO DEPOSITARIO BBVA SA. Nombramientos. EntidDeposit: BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA SA. Modificaciones estatutarias. 1. Denominaci贸n social.-. 9. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-.Datos registrales. T 28523 , F 144, S 8, H M 288363, I/A 24 ( 1.08.17).
01 de Julio de 2016Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MOSCARDO BENJAMIN;MARTINEZ MOSCARDO FRANCISCO GONZALO. Presidente:MARTINEZ MOSCARDO RAFAEL. Consejero: MARTINEZ MOSCARDO RAFAEL. Datos registrales. T 28523 , F 143, S 8, H M288363, I/A 23 (23.06.16).
13 de Julio de 2015Cambio de domicilio social. C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID). Datos registrales. T 28523 , F 143, S 8, H M 288363, I/A 22 (3.07.15).
15 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28523 , F 143, S 8, H M 288363, I/A 21 (26.08.14).
10 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Ent. Gestora: BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA. Nombramientos. Ent. Gestora: BBVA ASSETMANAGEMENT SA SGIIC. Apoderado: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC;BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC. Datosregistrales. T 28523 , F 142, S 8, H M 288363, I/A 20 (26.08.14).
05 de Septiembre de 2013Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN EL ARTICULO 13潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos:Determinaci贸n de la p谩gina web de la gestora como pagina webde la Sociedad. Datos registrales. T 28523 , F 141, S 8, H M 288363,I/A 19 (28.08.13).
13 de Noviembre de 2012Otros conceptos: AUMENTADO EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, QUE QUEDA FIJADO EN 1,25 EUROS,MODIFICANDO EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 28523 , F 141, S 8, H M 288363, I/A 18(29.10.12).
20 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Ent. Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC. EntidDeposit: SANTANDER INVESTMENT SA.Nombramientos. Ent. Gestora: BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA. EntidDeposit: BANCO DEPOSITARIO BBVA SA.Apoderado: BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1 Y 3 DELOS ESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de domicilio social. C/ PADILLA 17 (MADRID). Datos registrales. T 16867 , F 22, S 8, HM 288363, I/A 17 (29.08.11).
19 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: DIEZ MEDINA VERONICA. Nombramientos. VsecrNoConsj: LOUREIRO BOTANA CONCEPCION.Datos registrales. T 16867 , F 22, S 8, H M 288363, I/A 16 ( 7.09.11).
08 de Septiembre de 2011Revocaciones. Auditor: QUORUM AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T16867 , F 21, S 8, H M 288363, I/A 14 (12.08.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BONET RAMON GEMMA;ROMERO BUENROSTRO NICOLAS. Nombramientos. Consejero:MARTINEZ MOSCARDO BENJAMIN;MARTINEZ MOSCARDO FRANCISCO GONZALO. Reelecciones. Presidente: MARTINEZMOSCARDO RAFAEL. Consejero: MARTINEZ MOSCARDO RAFAEL. Datos registrales. T 16867 , F 22, S 8, H M 288363, I/A 15(16.08.11).
17 de Septiembre de 2010Nombramientos. Auditor: QUORUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16867 , F 21, S 8, H M 288363, I/A 13 ( 6.09.10).
21 de Septiembre de 2009Reelecciones. Auditor: B G T AUDITORES SL. Datos registrales. T 16867 , F 21, S 8, H M 288363, I/A 12 ( 9.09.09).