Buscador CIF Logo

Actos BORME All Funeral Services Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera All Funeral Services Sa

Actos BORME All Funeral Services Sa - A86354222

Tenemos registrados 39 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para All Funeral Services Sa con CIF A86354222

馃敊 Perfil de All Funeral Services Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de All Funeral Services Sa

16 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ SIERRAS ANA PILAR. Datos registrales. T 33439 , F 127, S 8, H M 530011, I/A 39 (8.11.23).

17 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ CUADRADO FRANCISCO-JAVIER;RIVERA ALMAGRO PATRICIA;SANZ AVILASVIRGINIA;MARTINEZ ESCRIBANO ALEJANDRA;FERNANDEZ DE BOBADILLA FUSTER JUAN. Datos registrales. T 33439 , F 126,S 8, H M 530011, I/A 38 ( 9.10.23).

25 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: BENAVIDES PIZARRO ANA ISABEL. Apo.Manc.: BENAVIDES PIZARRO ANA ISABEL. Datosregistrales. T 33439 , F 126, S 8, H M 530011, I/A 37 (18.11.22).

26 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ LOPEZ FERNANDO. Datos registrales. T 33439 , F 125, S 8, H M 530011, I/A 36(19.10.22).

01 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GAZTELUMENDI ERNESTO. Apo.Manc.: ARROYO LOPEZ OLGA. Apo.Sol.: SANZ AVILASVIRGINIA. Datos registrales. T 33439 , F 124, S 8, H M 530011, I/A 35 (22.07.22).

28 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: DELGADO MARTIN ISABEL;RUIZ BAZAGA ADOLFO;ALBA VARGAS ALFREDO;SANTOS BLANCAFERNANDO. Datos registrales. T 33439 , F 123, S 8, H M 530011, I/A 34 (20.07.22).

07 de Julio de 2022
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ LLORENS JOSE LUIS;SAGASETA VICENTE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T33439 , F 123, S 8, H M 530011, I/A 33 (30.06.22).

24 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: SANTOS BLANCA FERNANDO. Datos registrales. T 33439 , F 123, S 8, H M 530011, I/A 32(17.06.22).

02 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTIZ JOVER ALBERTO. Nombramientos. Adm. Solid.: LLAONA MENDOZA PEDRO RAMON.Datos registrales. T 33439 , F 122, S 8, H M 530011, I/A 31 (26.05.22).

09 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: CARRETERO CA脩ADO JAVIER;DEL VISO MARTIN SERGIO. Datos registrales. T 33439 , F 122, S 8,H M 530011, I/A 29 (29.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: CARRETERO CA脩ADO JAVIER;DEL VISO MARTIN SERGIO. Datos registrales. T 33439 , F 122, S 8,H M 530011, I/A 30 (29.04.22).

11 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: POLO RODRIGUEZ LUIS MARIA. Apoderado: POLO RODRIGUEZ LUIS MARIA;GONZALEZ CANALESJUAN CARLOS. Datos registrales. T 33439 , F 121, S 8, H M 530011, I/A 28 ( 4.10.21).

01 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33439 , F 121, S 8, H M 530011, I/A 27 (24.09.21).

29 de Julio de 2021
Reelecciones. Adm. Solid.: ORTIZ JOVER ALBERTO. Datos registrales. T 33439 , F 121, S 8, H M 530011, I/A 26 (22.07.21).

24 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: SANZ ISLA MARIA ELENA;BENAVIDES PIZARRO ANA ISABEL. Datos registrales. T 33439 , F 121,S 8, H M 530011, I/A 25 (17.05.21).

04 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: SAGASETA VICENTE FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ GOMBAU GLORIA;VI脩UALES HERMIDAPABLO;RODERO GARCIA JESUS. Datos registrales. T 33439 , F 120, S 8, H M 530011, I/A 24 (28.08.20).

19 de Marzo de 2020
Cambio de objeto social. El comercio de servicios funerarios, servicios plenos y tambi茅n diferenciados, con traslados nacionales einternacionales; contrataci贸n de estos servicios con otras empresas nacionales como con las de cualquier otra naci贸n y, en general, lasactividades propias de los servicios funerarios. Datos registrales. T 33439 , F 120, S 8, H M 530011, I/A 23 (12.03.20).

24 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VALDIVIA GERADA ANGEL. Nombramientos. Adm. Solid.: GARCIA MANZANO MARIAYOLANDA. Datos registrales. T 33439 , F 119, S 8, H M 530011, I/A 22 (15.04.19).

05 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MANZANO MARIA YOLANDA;DE MIGUEL ALONSO LUIS;FERNANDEZ DE LA FUENTEEDUARDO;SAGASETA VICENTE FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ GOMBAU GLORIA;VI脩UALES HERMIDA PABLO;RODEROGARCIA JESUS MIGUEL;QUERO FUERTES MIGUEL ANGEL;PEREZ DE LA ROCHA ESTIBALIZ;GONZALEZ MARTINEZELENA;ECHEVARRIA CRIADO ALEJANDRA;ALVAREZ SIERRAS ANA PILAR;ESTEVEZ COMAS RAFAEL JESUS;POLORODRIGUEZ LUIS MARIA;BERGAMIN SERRANO FRANCISCO JAVIER;MARTINEZ CUNHA MACARENA;GONZALEZ CANALESJUAN CARLOS;JUARANZ SAAVEDRA MIGUEL ANGEL;HERNANDO DE LA CUERDA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 33439 ,F 116, S 8, H M 530011, I/A 20 (26.02.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: DE MIGUEL ALONSO LUIS;SAGASETA VICENTE FRANCISCO JAVIER;QUERO FUERTES MIGUELANGEL;BERGAMIN SERRANO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 33439 , F 119, S 8, H M 530011, I/A 21 (26.02.19).

19 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: ESTEVEZ COMAS RAFAEL JESUS;POLO RODRIGUEZ LUIS MARIA;BERGAMIN SERRANOFRANCISCO JAVIER;SAAVEDRA DELGADO ALBERTO;HERNANDO DE LA CUERDA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 33439 ,F 115, S 8, H M 530011, I/A 19 (12.02.19).

18 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: MIRANDA FERNANDEZ PALOMA. Datos registrales. T 33439 , F 113, S 8, H M 530011, I/A 17(10.01.19).

Nombramientos. Apoderado: ARAGONES FERNANDEZ ROCIO;SANZ ISLA MARIA ELENA;BENAVIDES PIZARRO ANAISABEL;ARROYO LOPEZ OLGA;SANCHEZ SOPE脩A MARIA GEMA;GOMEZ DE CASTRO RAFAEL;FERNANDEZ GIL FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 33439 , F 113, S 8, H M 530011, I/A 18 (10.01.19).

05 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33439 , F 112, S 8, H M 530011, I/A 16 (25.10.18).

25 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ SIERRAS ANA PILAR. Nombramientos. Apoderado: MIRANDA FERNANDEZ PALOMA.Datos registrales. T 33439 , F 111, S 8, H M 530011, I/A 15 (19.04.18).

28 de Agosto de 2017
Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR ESQUERDO, 138, 5陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 33439 , F 111, S 8, H M530011, I/A 14 (18.08.17).

09 de Junio de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: MENDOZA CALVO MARIA CONCEPCION. Apoderado: MENDOZA CALVO MARIA CONCEPCION. Datosregistrales. T 33439 , F 111, S 8, H M 530011, I/A 13 (31.05.17).

28 de Enero de 2016
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ SIERRAS ANA PILAR. Datos registrales. T 33439 , F 110, S 8, H M 530011, I/A 12(19.01.16).

15 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: GUIJAR LOPEZ MONTSERRAT. Datos registrales. T 33439 , F 109, S 8, H M 530011, I/A 11 (4.12.15).

11 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33439 , F109, S 8, H M 530011, I/A 10 ( 2.12.15).

09 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: MENDOZA CALVO MARIA CONCEPCION. Consejero: VALDIVIA GERADA JUANANTONIO;VALDIVIA GERADA ANGEL;ORTIZ JOVER ALBERTO. Presidente: VALDIVIA GERADA JUAN ANTONIO. Con.Delegado:VALDIVIA GERADA ANGEL. Nombramientos. Adm. Solid.: ORTIZ JOVER ALBERTO;VALDIVIA GERADA ANGEL. Modificacionesestatutarias. DEROGACION DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD Y APROBACION DE UN NUEVO ARTICULADO, DECONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, QUE HA SIDO MODIFICADA POR LA LEY 31/2014, DE 3 DEDICIEMBRE.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios.Datos registrales. T 29445 , F 174, S 8, H M 530011, I/A 7 (29.05.15).

Nombramientos. Apoderado: ARAGONES FERNANDEZ ROCIO;BACHERO LOPEZ VICENTE;FERNANDEZ LLORENS JOSELUIS;ANTUNEZ DIAZ ALICIA;GRAGERA SANCHEZ CIPRIANO;MARTINEZ GARCIA JOSE. Datos registrales. T 29445 , F 178, S 8,H M 530011, I/A 8 (29.05.15).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ DE LA ROCHA ESTIBALIZ;GONZALEZ MARTINEZ ELENA. Datos registrales. T 33439 , F108, S 8, H M 530011, I/A 9 (29.05.15).

22 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: SANTOS HERNANDEZ RICARDO. Datos registrales. T 29445 , F 173, S 8, H M 530011, I/A 6 (15.04.15).

11 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 29445 , F 173, S 8, H M 530011, I/A 4 ( 2.12.14).

Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR ESQUERDO , 138 ,6& PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 29445 , F 173, S 8, H M 530011, I/A 5 ( 2.12.14).

15 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: MENDOZA CALVO MARIA CONCEPCION;SANTOS HERNANDEZ RICARDO. Datos registrales. T29445 , F 172, S 8, H M 530011, I/A 2 ( 7.10.13).

Nombramientos. Apoderado: MENDOZA CALVO MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 29445 , F 173, S 8, H M 530011, I/A3 ( 7.10.13).

18 de Enero de 2012
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.12.11. Objeto social: EL COMERCIO DE SERVICIOS FUNERARIOS. Domicilio: C/CASTELLO 66 1潞 (MADRID). Capital suscrito: 60.000,00 Euros. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad.Socio 煤nico: FUNESPA脩A SA. Nombramientos. Consejero: VALDIVIA GERADA JUAN ANTONIO;VALDIVIA GERADAANGEL;ORTIZ JOVER ALBERTO. Presidente: VALDIVIA GERADA JUAN ANTONIO. Con.Delegado: VALDIVIA GERADA ANGEL.Secretario: MENDOZA CALVO MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 29445 , F 170, S 8, H M 530011, I/A 1 ( 4.01.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n