Buscador CIF Logo

Actos BORME Alma It Systems Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Alma It Systems Sl

Actos BORME Alma It Systems Sl - B63893200

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Alma It Systems Sl con CIF B63893200

馃敊 Perfil de Alma It Systems Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Alma It Systems Sl

18 de Abril de 2023
Nombramientos. APODERAD.SOL: HERRERO JOVER JAVIER. Datos registrales. T 48506 , F 114, S 8, H B 309001, I/A 22(11.04.23).

12 de Diciembre de 2022
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 38498 , F156, S 8, H B 309001, I/A 21 ( 1.12.22).

28 de Octubre de 2022
Nombramientos. APODERAD.SOL: EGEA MARTINEZ AMPARO RAQUEL;CRUZ LLAUNA ANTONIO. Datos registrales. T 38498 ,F 156, S 8, H B 309001, I/A 20 (23.10.22).

01 de Agosto de 2022
Nombramientos. APODERAD.SOL: EGEA MARTINEZ AMPARO RAQUEL. Datos registrales. T 37700 , F 208, S 8, H B 309001,I/A 19 (22.07.22).

27 de Diciembre de 2021
Nombramientos. APODERAD.SOL: HERRERO JOVER JAVIER. Datos registrales. T 37700 , F 208, S 8, H B 309001, I/A 18(16.12.21).

16 de Noviembre de 2021
Revocaciones. ADM.UNICO: HERRERO JOVER JAVIER. Nombramientos. PRESIDENTE: HERRERO JOVER JAVIER.CONSEJERO: HERRERO JOVER JAVIER;HERRERO ANTON HUGO;3A MANAGEMENT SL. REPR.143 RRM: CRUZ LLAUNAANTONIO. CONSEJERO: BEATO BLANCO PAULINA;AMTRAK SL. REPR.143 RRM: GABARRO MIQUEL MARIA ISABEL.CONSEJERO: LOPEZ ALVAREZ JORDI. V-SEC NO CON: CAPDEVILA FONT ANA MARIA. SECRETARIO: AMTRAK SL.Modificaciones estatutarias. ARTICULO 17.- PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 37700 , F 207, S 8, H B 309001, I/A 17 ( 8.11.21).

27 de Noviembre de 2020
Cambio de domicilio social. CL MESTRE DALMAU Num.19 (BARCELONA). Datos registrales. T 37700 , F 207, S 8, H B 309001,I/A 16 (20.11.20).

08 de Marzo de 2017
Cambio de domicilio social. PS DE GRACIA Num.11 ESC.A P.2 PTA.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 37700 , F 206, S 8, HB 309001, I/A 15 (28.02.17).

20 de Diciembre de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.530,00 Euros. Resultante Suscrito: 222.530,00 Euros. Datos registrales. T 37700 , F 206, S 8, H B309001, I/A 14 (12.12.16).

09 de Enero de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: QUADRAS Y SERRA AUDITORES SL. Datos registrales. T 37700 , F 206, S 8, H B 309001, I/A13 (30.12.13).

28 de Marzo de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: HERRERO JOVER JAVIER. PRESIDENTE: HERRERO JOVER JAVIER. CONSEJERO: LOPEZALVAREZ JORDI. SECRETARIO: LOPEZ ALVAREZ JORDI. Nombramientos. ADM.UNICO: HERRERO JOVER JAVIER. Datosregistrales. T 37700 , F 205, S 8, H B 309001, I/A 10 (17.03.12).

Revocaciones. APODERADO: GIL DE BIEDMA RIVIERE JACOBO. Datos registrales. T 37700 , F 205, S 8, H B 309001, I/A 11(17.03.12).

Revocaciones. CONSEJERO: GIL DE BIEDMA RIVIERE JACOBO. CONS. DELEG.: GIL DE BIEDMA RIVIERE JACOBO. Datosregistrales. T 37700 , F 206, S 8, H B 309001, I/A 12 (17.03.12).

05 de Octubre de 2009
Revocaciones. ADM.UNICO: GIL DE BIEDMA RIVIERE JACOBO. Nombramientos. CONSEJERO: HERRERO JOVER JAVIER.PRESIDENTE: HERRERO JOVER JAVIER. CONSEJERO: GIL DE BIEDMA RIVIERE JACOBO. CONS. DELEG.: GIL DE BIEDMARIVIERE JACOBO. CONSEJERO: LOPEZ ALVAREZ JORDI. SECRETARIO: LOPEZ ALVAREZ JORDI. Datos registrales. T 37700 ,F 205, S 8, H B 309001, I/A 9 (22.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n