Actos BORME de Alma Media Sa
18 de Diciembre de 2023Cambio de denominaci贸n social. MEDIAPLUS ALMA SA. Datos registrales. T 27633 , F 214, S 8, H M 109445, I/A 77 (11.12.23).
08 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MALGARA ANDREA. Nombramientos. Consejero: BOSTROM ARVID HANNO CHRISTIAN.Reelecciones. Consejero: NODER MARKUS JOHANNES. Datos registrales. T 27633 , F 213, S 8, H M 109445, I/A 76 ( 1.09.23).
19 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDIA TEAM 3 VALUE & INVESTMENTS SL. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n70陋 la publicaci贸n del cese de MEDIA TEAM 3 VALUE & INVESTMENTS SL como consejero. Datos registrales. T 27633 , F 209, S 8,H M 109445, I/A 70 (19.11.19).
04 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 27633 , F 213, S 8, H M 109445, I/A 75 (28.07.22).
07 de Julio de 2022Reelecciones. Consejero: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS;MU脩OZ ORTEGA ANA MARIA;MARTINEZ MARTIN OSCAR.Presidente: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS. Con.Delegado: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS. Vicepresid.: MARTINEZMARTIN OSCAR. Datos registrales. T 27633 , F 213, S 8, H M 109445, I/A 74 (30.06.22).
11 de Agosto de 2021Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 27633 , F 212, S 8, H M 109445, I/A 73 ( 4.08.21).
23 de Junio de 2021Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 31. Datos registrales. T 27633 , F 212, S 8, H M 109445, I/A 72 (16.06.21).
25 de Marzo de 2020Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 27633 , F 212, S 8, H M 109445, I/A 71 (18.03.20).
26 de Noviembre de 2019P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Nombramientos. Consejero: DE ROJAS TORIBIO JOSE LUIS. Fusi贸n por uni贸n.Sociedades que se fusi贸nan: MEDIA TEAM 3 VALUE & INVESTMENTS SL. Datos registrales. T 27633 , F 209, S 8, H M 109445, I/A70 (19.11.19).
07 de Agosto de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MEDIA TEAM 3 VALUE & INVESTMENTS SL. Datos registrales. T 27633 , F 209,S 8, H M 109445, I/A 69 (31.07.19).
28 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ FERNANDEZ ROMAN IGNACIO;PE脩A DE ORIOL GONZALO. Nombramientos.Consejero: PRUSCHENK FABIAN HERMANN;BRULL MATTIAS. Datos registrales. T 27633 , F 208, S 8, H M 109445, I/A 68(21.06.19).
29 de Abril de 2019Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 27633 , F 208, S 8, H M 109445, I/A 67 (22.04.19).
19 de Febrero de 2019Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 26 de los estatutos sociales .-. Datos registrales. T 27633 , F207, S 8, H M 109445, I/A 66 (12.02.19).
06 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ DEORADOR JUAN ANTONIO. Nombramientos. Consejero: ZERTEM GRUPO DECOMUNICACION SL. Representan: DE ROJAS TORIBIO JOSE LUIS. Datos registrales. T 27633 , F 207, S 8, H M 109445, I/A 65(26.10.18).
08 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: USTARA GORBE脩A ALFREDO. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ DEORADOR JUAN
24 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Representan: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS. Nombramientos. Representan: DE ROJAS TORIBIOJOSE LUIS. Datos registrales. T 27633 , F 206, S 8, H M 109445, I/A 63 (16.05.17).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. Consejero: MALGARA ANDREA;NODER MARKUS JOHANNES. Modificaciones estatutarias. MODIFICACIONDE LOS ARTICULOS 19, 23 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 27633 , F 204, S 8, H M 109445, I/A 62(13.03.17).
31 de Enero de 2017Otros conceptos: Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia dela escritura de fusi贸n y segregaci贸n que caus贸 la inscripci贸n 1陋 de la hoja 624.626. Datos registrales. T 27633 , F 202, S 8, H M109445, I/A 57M (16.01.17).
28 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ MARTIN OSCAR. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MARTIN OSCAR. Apo.Manc.: MU脩OZ ORTEGAANA MARIA. Datos registrales. T 27633 , F 202, S 8, H M 109445, I/A 58 (19.07.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ ORTEGA ANA MARIA. Apo.Manc.: MARTINEZ MARTIN OSCAR. Datos registrales. T27633 , F 203, S 8, H M 109445, I/A 59 (19.07.16).
Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 26 de los estatutos sociales -. Datos registrales. T 27633 , F 203,S 8, H M 109445, I/A 60 (19.07.16).
Reelecciones. Consejero: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS;MU脩OZ ORTEGA ANA MARIA;MARTINEZ MARTINOSCAR;RODRIGUEZ FERNANDEZ ROMAN IGNACIO;PE脩A DE ORIOL GONZALO. Presidente: GUTIERREZ VIGARA JOSECARLOS. Con.Delegado: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS. Vicepresid.: MARTINEZ MARTIN OSCAR. Consejero: MEDIA TEAM3 VALUE & INVESTMENTS SL;USTARA GORBE脩A ALFREDO. Representan: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS. Datosregistrales. T 27633 , F 204, S 8, H M 109445, I/A 61 (19.07.16).
05 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 27633 , F 201, S 8, H M 109445, I/A 57 (23.03.16).
21 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ ASO IGNACIO. Vicepresid.: RODRIGUEZ FERNANDEZ ROMAN IGNACIO. Nombramientos.Representan: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS. Vicepresid.: MARTINEZ MARTIN OSCAR. Consejero: MEDIA TEAM 3 VALUE &INVESTMENTS SL;USTARA GORBE脩A ALFREDO. Datos registrales. T 27633 , F 201, S 8, H M 109445, I/A 56 ( 9.05.12).
11 de Abril de 2012Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 43 5& (MADRID). Datos registrales. T 27633 , F 201, S 8, H M 109445,I/A 55 (27.03.12).
09 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ ORTEGA ANA MARIA;MARTINEZ MARTIN OSCAR. Datos registrales. T 27633 , F 199, S 8,H M 109445, I/A 53 (30.01.12).
Revocaciones. Apoderado: DIAZ COLMENAR FRANCISCO JAVIER;DEL BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS;MARTINEZSANCHEZ GEMA MATILDE. Datos registrales. T 27633 , F 200, S 8, H M 109445, I/A 54 (30.01.12).
29 de Diciembre de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 813.468,60 Euros. Resultante Suscrito: 1.178.699,40 Euros. Datos registrales. T 27633 ,F 199, S 8, H M 109445, I/A 52 (19.12.11).
09 de Marzo de 2011Nombramientos. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 27633 , F 199, S 8, H M109445, I/A 51 (23.02.11).
16 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: NAVEA ATORRASAGASTI JORGE. Secretario: MU脩OZ DE VERGER GARCIA ANTONIO.VsecrNoConsj: BARRIENTOS CERRA MARIA JESUS;AGUILAR VELASCO MARIA ANGELA. Consejero: PEREZ DE VILLAAMIL YALFARO LEOPOLDO;GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS;BERGE AUTOMOCION SL;ENCISO BERGE PEDRO. Cons.Del.Sol:GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS. Consejero: RODRIGUEZ AFAN DE RIBERA BORJA. Presidente: ENCISO BERGE PEDRO.VsecrNoConsj: BAUTISTA ENCISO SALVADOR. Nombramientos. SecreNoConsj: VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZFERNANDO. Consejero: GUTIERREZ VIGARA JOSE CARLOS;MU脩OZ ORTEGA ANA MARIA;MARTINEZ MARTINOSCAR;RODRIGUEZ FERNANDEZ ROMAN IGNACIO;RUIZ ASO IGNACIO;PE脩A DE ORIOL GONZALO. Presidente: GUTIERREZVIGARA JOSE CARLOS. Vicepresid.: RODRIGUEZ FERNANDEZ ROMAN IGNACIO. Con.Delegado: GUTIERREZ VIGARA JOSECARLOS. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 700.002,00 Euros. Desembolsado: 700.002,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.992.168,00Euros. Resultante Desembolsado: 1.992.168,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Modificados y refundidos los estatutossociales.. Datos registrales. T 6720 , F 225, S 8, H M 109445, I/A 50 ( 2.07.10).
30 de Junio de 2010Cambio de domicilio social. C/ MONTALBAN 5 (MADRID). Datos registrales. T 6720 , F 224, S 8, H M 109445, I/A 49 (17.06.10).
28 de Junio de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 762.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 183.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 1.109.166,00 Euros. Desembolsado: 1.109.166,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.292.166,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 1.292.166,00 Euros. Datos registrales. T 6720 , F 224, S 8, H M 109445, I/A 48 (16.06.10).
05 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 6720 , F 223, S 8, H M 109445, I/A 47(26.01.10).
13 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Representan: D ORNELLAS SILVA FERNANDO. Nombramientos. Representan: NAVEA ATORRASAGASTIJORGE. Datos registrales. T 6720 , F 223, S 8, H M 109445, I/A 46 ( 4.08.09).
23 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: DEL BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS. Datos registrales. T 6720 , F 221, S 8, H M 109445, I/A 44(10.07.09).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ GEMA MATILDE. Datos registrales. T 6720 , F 223, S 8, H M 109445, I/A 45(10.07.09).
10 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: USTARA GORBE脩A ALFREDO. Presidente: USTARA GORBE脩A ALFREDO. Consejero: USTARAGORBE脩A ALFREDO;CONTRERAS ORTEGA EMILIO;ERASO CAMPUZANO ANTONIO;BENDELAC SAMUEL STANLEY.Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ AFAN DE RIBERA BORJA. Presidente: ENCISO BERGE PEDRO. Datos registrales. T6720 , F 221, S 8, H M 109445, I/A 43 (30.06.09).