Actos BORME de Alma Telecom Sociedad Limitada
04 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPENGER MEINRAD. Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ CALERO SERVANDO. Apo.Sol.:CASTA脩EDA GONZALEZ ALBERTO;GARCIA SANCHEZ JESUS MARIA;JUANAS FABEIRO ALEXANDRA;MARTOS RIPOLLJORGE. Apo.Man.Soli: GONZALEZ TEJERA REBECA;TEJEDOR CUESTA OSCAR;SANTOS FERNANDEZ MIGUEL;MONTEROSANCHEZ ANTONIO;LOPEZ TELLO HERRERA JOSE CARLOS;CALVO GOMEZ JOSE MANUEL;LOPEZ GRANADOSBELEN;GUERRERO FERRER VICTOR;MARIN HUMBERT GUILLAUME PIERRE ANTOINE;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCOJAVIER;DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS;LOPEZ FERNANDEZ JOSE GERMAN;SUAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL;MEDINASANTAMARIA ARTURO;FREIRE BARRAL PABLO;CARDONA ARRANZ BELEN;LOIS CIGARRAN PEDRO;PASCUAL ZARATEPILAR. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1029, L 793, F 108, S 8, H AB 5723, I/ACIERR (28.03.22).
01 de Marzo de 2022Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL.- No existiendo obst谩culos registrales para la fusi贸n por absorci贸n pretendida entre laSociedad Spotting Brands TEchnologies Sociedad Limitada Unipersonal, y la mercantil de 茅sta hoja, se extiende nota de cierreprovisional de la Sociedad, durante seis meses, seg煤n lo dispuesto en el Art铆culo 231 del R.R.M, y la inexistencia de obstaculos.Datos registrales. T 1029, L 793, F 108, S 8, H AB 5723, I/ADILIG (22.02.22).
24 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: LUQUE RUIZ DE MIER FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1029, L 793, F 107, S 8, H AB 5723,I/A 27 (17.06.21).
07 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CASTA脩EDA GONZALEZ ALBERTO;GARCIA SANCHEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 1013, L777, F 166, S 8, H AB 5723, I/A 15 (29.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: JUANAS FABEIRO ALEXANDRA. Datos registrales. T 1013, L 777, F 166, S 8, H AB 5723, I/A 16(29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ TEJERA REBECA. Datos registrales. T 1029, L 793, F 98, S 8, H AB 5723, I/A 17(29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS FERNANDEZ MIGUEL;MONTERO SANCHEZ ANTONIO. Datos registrales. T 1029, L793, F 98, S 8, H AB 5723, I/A 18 (29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUQUE RUIZ DE MIER FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1029, L 793, F 99, S 8, H AB5723, I/A 19 (29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDOR CUESTA OSCAR. Datos registrales. T 1029, L 793, F 100, S 8, H AB 5723, I/A 20(29.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTOS RIPOLL JORGE. Datos registrales. T 1029, L 793, F 101, S 8, H AB 5723, I/A 21 (29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ TELLO HERRERA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 1029, L 793, F 101, S 8, H AB5723, I/A 22 (29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASCUAL ZARATE PILAR. Datos registrales. T 1029, L 793, F 101, S 8, H AB 5723, I/A 23(29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GRANADOS BELEN. Datos registrales. T 1029, L 793, F 103, S 8, H AB 5723, I/A 24(29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUERRERO FERRER VICTOR;MARIN HUMBERT GUILLAUME PIERRE ANTOINE;MARIN DE LAPLAZA FRANCISCO JAVIER;DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS;LOPEZ FERNANDEZ JOSE GERMAN;SUAREZ GARCIA MIGUELANGEL;MEDINA SANTAMARIA ARTURO;FREIRE BARRAL PABLO. Datos registrales. T 1029, L 793, F 104, S 8, H AB 5723, I/A 25(29.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARDONA ARRANZ BELEN;LOIS CIGARRAN PEDRO;CALVO GOMEZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 1029, L 793, F 106, S 8, H AB 5723, I/A 26 (29.03.21).
17 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPOTTING BRANDS TECHNOLOGY SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Unico:SPENGER MEINRAD. Datos registrales. T 1013, L 777, F 166, S 8, H AB 5723, I/A 14 (10.03.21).
23 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ CALERO SERVANDO. Nombramientos. Adm. Unico: SPOTTING BRANDSTECHNOLOGY SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 710, L 474, F 5, S 8, H AB 5723, I/A 12 (16.12.19).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CALERO SERVANDO. Datos registrales. T 710, L 474, F 5, S 8, H AB 5723, I/A 13(16.12.19).
05 de Noviembre de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SPOTTING BRANDS TECHONOLOGIES SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 710, L 474, F 4, S 8, H AB 5723, I/A 11 (28.10.19).
24 de Abril de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.020,20 Euros. Resultante Suscrito: 96.161,60 Euros. Datos registrales. T 710, L 474, F4, S 8, H AB 5723, I/A 10 (17.04.17).
08 de Octubre de 2015Revocaciones. Auditor: GOMEZ ESCRIBANO MARIA JOSEFA. Aud.Supl.: SEIQUER AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDADLIMITADA. Datos registrales. T 710, L 474, F 4, S 8, H AB 5723, I/A 9 ( 1.10.15).