Actos BORME de Almacenes Agrupados Mat Sl
22 de Febrero de 2023Revocaciones. Auditor: DYM AUDITORES Y CONSULTORES AGRUPADOS S.L. Nombramientos. Auditor: ATA AUDITORES S.L.Datos registrales. T 793 , F 111, S 8, H BA 24582, I/A 15 (15.02.23).
16 de Marzo de 2020Otros conceptos: La mercantil "PREFABRICADOS MANZANO, S.L." ha cambiado la persona f铆sica que la representa comoConsejera de la de esta Hoja, cesando a Don Francisco -conocido por Antonio- Manzano Carrasco y designando a DON JUANFRANCISCO MANZANO CARRASCO. Datos registrales. T 560 , F 15, S 8, H BA 24582, I/A 11 ( 9.03.20).
Reelecciones. Auditor: DYM AUDITORES Y CONSULTORES AGRUPADOS S.L. Datos registrales. T 560 , F 15, S 8, H BA 24582,I/A 12 ( 9.03.20).
22 de Enero de 2015Nombramientos. Auditor: DYM AUDITORES Y CONSULTORES AGRUPADOS SL. Aud.Supl.: MARTIN MORALES LUIS. Datosregistrales. T 560 , F 15, S 8, H BA 24582, I/A 10 (15.01.15).
25 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 560 , F 14, S 8, H BA 24582, I/A 7 (18.11.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ BURGUILLOS JOSE ANTONIO;FRANCO CALVO DIEGO. Datos registrales. T 560 , F14, S 8, H BA 24582, I/A 8 (18.11.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTIN ALVAREZ JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: DIEZ CONTRERAS FRANCISCO. Datos registrales.T 560 , F 15, S 8, H BA 24582, I/A 9 (18.11.14).
28 de Junio de 2013Nombramientos. Consejero: GARZON MATERIALES DE CONSTRUCCION SL. Datos registrales. T 560 , F 13, S 8, H BA 24582,I/A 6 (21.06.13).
22 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO;ALVAREZ BURGUILLOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T560 , F 13, S 8, H BA 24582, I/A 5 (14.05.13).
08 de Marzo de 2013Nombramientos. Consejero: SIERRA DE GATA-MORALEJA S.L. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 62.900,00 Euros.Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 313.390,00 Euros. Resultante Suscrito: 313.390,00 Euros.Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 8. Capital.-.Art铆culo de los estatutos: 8. Capital.-. Datos registrales. T 560 , F11, S 8, H BA 24582, I/A 4 ( 1.03.13).
26 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Domicilio.-.24. Administraci贸n y Representacion.-. Cambio de domiciliosocial. PRAJE EL SE脩ORIO, PARCELA 60 (TORREMEJIA). Datos registrales. T 560 , F 10, S 8, H BA 24582, I/A 2 (19.02.13).
Ceses/Dimisiones. Secretario: MATERIALES DE CONSTRUCCION RIVERO SL. Cons.Del.Sol: MATERIALES DE CONSTRUCCIONRIVERO SL. Nombramientos. Secretario: PREFABRICADOS MANZANO SL. Datos registrales. T 560 , F 11, S 8, H BA 24582, I/A3 (19.02.13).
02 de Agosto de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: MENDIANO CALLE MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: MENDIANO CALLE MIGUEL ANGEL;MARTIN ALVAREZJUAN CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEZ CONTRERAS FRANCISCO. Apo.Manc.: MARTIN ALVAREZ JUAN CARLOS.Datos registrales. T 677, L 505, F 140, S 8, H CC 8353, I/A 7 (23.07.12).
14 de Octubre de 2011Nombramientos. Auditor: MARTIN MORALES LUIS. Aud.Supl.: DYM AUDITORES Y CONSULTORES AGRUPADOS SL. Datosregistrales. T 677, L 505, F 140, S 8, H CC 8353, I/A 6 ( 3.10.11).