Buscador CIF Logo

Actos BORME Almacenes Central De Compras Y Servicios Ccs Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Almacenes Central De Compras Y Servicios Ccs Sl

Actos BORME Almacenes Central De Compras Y Servicios Ccs Sl - B81985673

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Almacenes Central De Compras Y Servicios Ccs Sl con CIF B81985673

馃敊 Perfil de Almacenes Central De Compras Y Servicios Ccs Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Almacenes Central De Compras Y Servicios Ccs Sl

23 de Mayo de 2018
Extinci贸n. Datos registrales. T 36396 , F 2, S 8, H M 210754, I/A 32 (14.05.18).

28 de Julio de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.000,00 Euros. Datos registrales. T 24602 , F 111,S 8, H M 210754, I/A 28 (18.07.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: NARANJO CALLEJA JAIR. Datos registrales. T 24602 , F 111, S 8, H M 210754, I/A 29 (19.07.17).

21 de Julio de 2017
Modificaciones estatutarias. Modificacion del articulo 28 de los estatutos sociales . Datos registrales. T 24602 , F 106, S 8, H M210754, I/A 24 (12.07.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: OBIOLS SENET JOSE;CORNELLA SOLA JOSEP MARIA. Presidente: CORNELLA SOLA JOSEPMARIA. Revocaciones. Apo.Manc.: CORNELLA SOLA JOSEP MARIA;PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos.Presidente: SANZ ARRIBAS GUILLERMO JOSE. Apo.Manc.: SANZ ARRIBAS GUILLERMO;PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 24602 , F 107, S 8, H M 210754, I/A 25 (12.07.17).

Ceses/Dimisiones. Consj. Supl.: LANAU FELIP MIQUEL ANGEL. Consejero: SANZ ARRIBAS GUILLERMO JOSE;HERREROSGOMEZ CARLOS. Consj. Supl.: RIOS BRULL FRANCISCO;PEREZ DUQUE JUANA MARIA. Consejero: PEREZ GONZALEZ JOSEANTONIO. Secretario: PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO. Presidente: SANZ ARRIBAS GUILLERMO JOSE. Revocaciones.Apo.Manc.: SANZ ARRIBAS GUILLERMO;PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: ALAYON MELOLUIS;NARANJO CALLEJA JAIR;CUARTERO RUIZ JUAN;MU脩OZ CASTILLA RAFAEL;SANCHEZ JIMENEZ DIEGO. Presidente:SANCHEZ JIMENEZ DIEGO. Apo.Manc.: SANCHEZ JIMENEZ DIEGO;REY GARCIA CLAUDIO. SecreNoConsj: REY GARCIACLAUDIO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 37.000,00 Euros. Datos registrales. T24602 , F 108, S 8, H M 210754, I/A 26 (12.07.17).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LA ROCHA ESQUIVEL JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: REY GARCIA CLAUDIO.

11 de Octubre de 2013
Reelecciones. Consejero: CORNELLA SOLA JOSEP MARIA;PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO. Secretario: PEREZ GONZALEZJOSE ANTONIO. Presidente: CORNELLA SOLA JOSEP MARIA. Datos registrales. T 24602 , F 106, S 8, H M 210754, I/A 23 (4.10.13).

12 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: HURTADO CARRACEDO IGNACIO LUIS;GONZALEZ GARCIA ISABEL. Presidente: GONZALEZGARCIA ISABEL. ConsejSuplen: OBIOLS BENET JOSEP;SANZ ARRIBAS GUILLERMO. Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZGARCIA ISABEL;CUARTERO RUIZ JUAN. Nombramientos. Consejero: SANZ ARRIBAS GUILLERMO JOSE;OBIOLS SENETJOSE;HERREROS GOMEZ CARLOS. ConsejSuplen: RIOS BRULL FRANCISCO;PEREZ DUQUE JUANA MARIA. Presidente:CORNELLA SOLA JOSEP MARIA. Apo.Manc.: CORNELLA SOLA JOSEP MARIA;PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 24602 , F 105, S 8, H M 210754, I/A 22 (29.06.12).

25 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CUARTERO RUIZ JUAN. Secretario: CUARTERO RUIZ JUAN. Nombramientos. Secretario: PEREZGONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 24602 , F 104, S 8, H M 210754, I/A 21 (14.06.12).

20 de Diciembre de 2011
Nombramientos. ConsejSuplen: OBIOLS BENET JOSEP;LANAU FELIP MIQUEL ANGEL;SANZ ARRIBAS GUILLERMO.Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 41.000,00 Euros. Datos registrales. T 24602 , F 104,S 8, H M 210754, I/A 20 ( 5.12.11).

11 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA ROCHA ESQUIVEL JAVIER;SERRA PUIG JOAN ANTONI. Presidente: SERRA PUIG JOANANTONI. Secretario: DE LA ROCHA ESQUIVEL JAVIER. ConsejSuplen: CORNELLA SOLA JOSEP MARIA;PEREZ GONZALEZ JOSEANTONIO. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GALCERAN PI脩OL MARIA ASSUMPTA;PENA VILLAR JOSEMANUEL. Revocaciones. Apo.Man.Soli: SERRA PUIG JOAN ANTONI. Apo.Manc.: DE LA ROCHA ESQUIVEL JAVIER.Nombramientos. Consejero: CORNELLA SOLA JOSEP MARIA;PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO. Presidente: GONZALEZGARCIA ISABEL. Secretario: CUARTERO RUIZ JUAN. Apo.Manc.: GONZALEZ GARCIA ISABEL;CUARTERO RUIZ JUAN.Apo.Man.Soli: DE LA ROCHA ESQUIVEL JAVIER. Apo.Manc.: HURTADO CARRACEDO IGNACIO LUIS;PEREZ GONZALEZ JOSEANTONIO;CORNELLA SOLA JOSEP MARIA. Cambio de domicilio social. PLAZA DE CASTILLA 3 5潞 C2 (MADRID). Datosregistrales. T 24602 , F 103, S 8, H M 210754, I/A 19 ( 1.08.11).

11 de Diciembre de 2009
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Presidente: REY GARCIA CLAUDIO. Consejero: REY GARCIA CLAUDIO. Secretario:SANCHEZ JIMENEZ DIEGO. Consejero: SANCHEZ JIMENEZ DIEGO;PEREA POLVOROSA CARLOS;FERNANDEZ MARTINEZLUIS ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: REY GARCIA CLAUDIO;SANCHEZ JIMENEZ DIEGO;REY GARCIA CLAUDIO.Nombramientos. Consejero: HURTADO CARRACEDO IGNACIO LUIS;GONZALEZ GARCIA ISABEL;CUARTERO RUIZ JUAN.ConsejSuplen: CORNELLA SOLA JOSEP MARIA;PEREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO. Presidente: SERRA PUIG JOAN ANTONI.Secretario: DE LA ROCHA ESQUIVEL JAVIER. Apo.Man.Soli: SERRA PUIG JOAN ANTONI. Apo.Manc.: DE LA ROCHA ESQUIVELJAVIER. Datos registrales. T 24602 , F 102, S 8, H M 210754, I/A 18 ( 1.12.09).

06 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ TABARES ANGEL ANDRONICO. Nombramientos. Consejero: DE LA ROCHA ESQUIVELJAVIER;SERRA PUIG JOAN ANTONI. Datos registrales. T 24602 , F 102, S 8, H M 210754, I/A 17 (27.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n