Actos BORME de Almacenes Maritimos Del Sur Cadiz Sl
22 de Enero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: PAGE AU脩ON JULIO ENRIQUE;DURAN BENITEZ PATRICIO. Datos registrales. T 2154 , F 42, S 8, HCA 35906, I/A 7 (15.01.19).
03 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARGONZALEZ FIGAREDO ROMUALDO;ALVARGONZALEZ FIGAREDO GONZALO;PORTILLOSERRANO FERNANDO;PORTILLO SERRANO JOSE ANTONIO. Presidente: PORTILLO SERRANO JOSE ANTONIO. Secretario:PORTILLO SERRANO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: SIERRAPORT SL;BARUK THE FAMILY CONCEPT SL;ERSHIPSA;ALVARGONZALEZ SA. Presidente: BARUK THE FAMILY CONCEPT SL. Secretario: SIERRAPORT SL. Modificacionesestatutarias. Art铆culo 16潞.- . Datos registrales. T 2154 , F 39, S 8, H CA 35906, I/A 6 (27.07.16).
03 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PORTILLO SERRANO FERNANDO;PORTILLO SERRANO JOSE ANTONIO. Nombramientos.Consejero: ALVARGONZALEZ FIGAREDO ROMUALDO;ALVARGONZALEZ FIGAREDO GONZALO;PORTILLO SERRANOFERNANDO;PORTILLO SERRANO JOSE ANTONIO. Presidente: PORTILLO SERRANO JOSE ANTONIO. Secretario: PORTILLOSERRANO FERNANDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 2154 , F 39, S 8, H CA 35906, I/A 4 (21.01.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: PORTILLO SERRANO FERNANDO;PORTILLO SERRANO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2154 ,F 39, S 8, H CA 35906, I/A 5 (21.01.16).
11 de Mayo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n:ALMACENES MARITIMOS DEL SUR SL. Datos registrales. T 1870 , F 14, S 8, H CA 35906, I/A 3 ( 4.05.15).
06 de Agosto de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 496.900,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.000,00 Euros. Datos registrales. T 1870 , F 13, S 8, HCA 35906, I/A 2 (25.07.12).