Actos BORME de Almudi Sociedad Anonima
02 de Noviembre de 2022Modificaciones estatutarias. Creaci贸n de 2.650 acciones de Clase A, con privilegio especial, y de 600 acciones de Clase B,modificando el art铆culo 5潞 de los estatutos sociales. . Datos registrales. T 3703, L 1015, F 74, S 8, H V 13926, I/A 23 (25.10.22).
20 de Julio de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 130.548,80 Euros. Resultante Suscrito: 60.101,21 Euros. Datos registrales. T 3703, L1015, F 74, S 8, H V 13926, I/A 22 (13.07.21).
30 de Marzo de 2021Cambio de domicilio social. C/ PINTOR NAVARRO LLORENS 19 3 6 (VALENCIA). Datos registrales. T 3703, L 1015, F 74, S 8, HV 13926, I/A 21 (23.03.21).
11 de Mayo de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 199.999,99 Euros. Resultante Suscrito: 190.650,01 Euros. Datos registrales. T 3703, L1015, F 73, S 8, H V 13926, I/A 20 ( 4.05.20).
05 de Julio de 2019Reelecciones. Consejero: CA脩AMARES CORTES FELICIA;SEGARRA CA脩AMARES LAURA;SANCHO MERCE JAVIER;SANCHEZOLMO BAUTISTA;CABRERA CASARES GONZALO;SANCHEZ FRANCO JUAN BAUTISTA. Presidente: SANCHO MERCE JAVIER.Secretario: SANCHEZ OLMO BAUTISTA. Con.Delegado: SANCHEZ FRANCO JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 3703, L 1015,F 73, S 8, H V 13926, I/A 19 (28.06.19).
12 de Noviembre de 2015Reelecciones. Consejero: CA脩AMARES CORTES FELICIA;SEGARRA CA脩AMARES LAURA;SANCHO MERCE JAVIER;SANCHEZOLMO BAUTISTA;CABRERA CASARES GONZALO;SANCHEZ FRANCO JUAN BAUTISTA. Presidente: SANCHO MERCE JAVIER.Secretario: SANCHEZ OLMO BAUTISTA. Con.Delegado: SANCHEZ FRANCO JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 3703, L 1015,F 73, S 8, H V 13926, I/A 18 ( 4.11.15).
23 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ OLMO BAUTISTA. Datos registrales. T 3703, L 1015, F 72, S 8, H V 13926, I/A 17(14.11.11).
03 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: CABRERA BARRERO GONZALO;CA脩AMARES CORTES FELICIA;SEGARRA CA脩AMARESLAURA;SANCHO MERCE JAVIER;SANCHEZ OLMO BAUTISTA;SANCHEZ FRANCO JUAN BAUTISTA;CABRERA CASARESGONZALO. Presidente: SANCHO MERCE JAVIER. Secretario: CABRERA BARRERO GONZALO. Cons.Del.Sol: SANCHEZ OLMOBAUTISTA;SANCHEZ FRANCO JUAN BAUTISTA. Nombramientos. Consejero: CA脩AMARES CORTES FELICIA;SEGARRACA脩AMARES LAURA;SANCHO MERCE JAVIER;SANCHEZ OLMO BAUTISTA;CABRERA CASARES GONZALO;SANCHEZFRANCO JUAN BAUTISTA. Presidente: SANCHO MERCE JAVIER. Secretario: SANCHEZ OLMO BAUTISTA. Con.Delegado:SANCHEZ FRANCO JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 3703, L 1015, F 72, S 8, H V 13926, I/A 16 (24.10.11).
03 de Agosto de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 67.612,50 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO QUINTO.- Elcapital social se fija en TRESCIENTOSNOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS, 390.650'00 Euros, dividido en TRES MILDOSCIENTAS CINCUENTA, 3.250, ACCIONES NOMINATIVAS de CIENTO VEINTE EUROS CON VEINTE CENTIMOS, 120,20Euros, cada una de ellas, totalmente suscritas. Las. Datos registrales. T 3703, L 1015, F 71, S 8, H V 13926, I/A 15 (23.07.09).