Buscador CIF Logo

Actos BORME Alonville Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Alonville Sa

Actos BORME Alonville Sa - A33099029

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Alonville Sa con CIF A33099029

🔙 Perfil de Alonville Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Alonville Sa

21 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO VILLARON SONIA;MARQUETA SANCHEZ MARIA PILAR. Datos registrales. T 21297 , F176, S 8, H M 378383, I/A 16 (14.06.22).

06 de Abril de 2022
Cambio de domicilio social. C/ MORETO 8 - BAJO IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 21297 , F 176, S 8, H M 378383,I/A 15 (30.03.22).

22 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Consejero: VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Presidente: VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Consejero:ALONSO VILLARON SONIA. Secretario: ALONSO VILLARON SONIA. Consejero: ALONSO VILLARON DANIEL;ALONSO VILLARONORLANDO;ALONSO VILLARON JESUS. Datos registrales. T 21297 , F 175, S 8, H M 378383, I/A 14 (15.11.21).

09 de Octubre de 2018
Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 57 6º - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 21297 , F 175, S 8, H M 378383,I/A 13 ( 2.10.18).

25 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ VILA MANUEL. Datos registrales. T 21297 , F 174, S 8, H M 378383, I/A 12 (18.10.17).

02 de Febrero de 2017
Cambio de domicilio social. C/ MONTE ESQUINZA 34 7º A (MADRID). Datos registrales. T 21297 , F 174, S 8, H M 378383, I/A11 (25.01.17).

16 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Consejero: VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Presidente: VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Consejero:ALONSO VILLARON SONIA. Secretario: ALONSO VILLARON SONIA. Consejero: ALONSO VILLARON DANIEL;ALONSO VILLARONORLANDO;ALONSO VILLARON JESUS. Datos registrales. T 21297 , F 173, S 8, H M 378383, I/A 10 ( 8.09.15).

18 de Marzo de 2015
Ampliación de capital. Suscrito: 261.139,76 Euros. Desembolsado: 261.139,76 Euros. Resultante Suscrito: 3.224.129,43 Euros.Resultante Desembolsado: 3.224.129,43 Euros. Datos registrales. T 21297 , F 173, S 8, H M 378383, I/A 9 (10.03.15).

04 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apoderado: ALONSO VILLARON DANIEL;ALONSO VILLARON ORLANDO;ALONSO VILLARON JESUS. Datosregistrales. T 21297 , F 171, S 8, H M 378383, I/A 8 (26.09.13).

30 de Enero de 2012
Cambio de domicilio social. C/ ADOLFO PEREZ ESQUIVEL 3 - EDIFICIO LAS AMERICAS (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 21297 , F 171, S 8, H M 378383, I/A 7 (17.01.12).

15 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Consejero: VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Presidente: VILLARON DIEGO MARIA AGUSTINA. Consejero:ALONSO VILLARON SONIA. Secretario: ALONSO VILLARON SONIA. Consejero: ALONSO VILLARON DANIEL;ALONSO VILLARONORLANDO;ALONSO VILLARON JESUS. Datos registrales. T 21297 , F 170, S 8, H M 378383, I/A 6 ( 1.12.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información