Actos BORME de Alosa Autocares Y Autobuses Sociedad Limitada
21 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ALONSO SOROA VALENTIN;DURAN REGIS MARTHA ANGELICA;ROMAN SANCHEZ-RUBIOJOSE LUIS. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 631 , F 222, S 8, H HU 9479, I/A 53 D (14.10.21).
16 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 631 , F 222, S 8, H HU 9479, I/A 53 ( 6.11.20).
13 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: ROMAN SANCHEZ-RUBIO JOSE LUIS. Datos registrales. T 631 , F 170, S 8, H HU 9479, I/A 52 (9.03.20).
05 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 631 , F 170, S 8, H HU 9479, I/A 51 (28.10.19).
10 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ ABAD PEDRO RAMON. Apo.Manc.: GOMEZ ABAD PEDRO RAMON. Apo.Sol.: PEREZ ZAPATAANDRES. Apo.Manc.: PEREZ ZAPATA ANDRES. Datos registrales. T 631 , F 169, S 8, H HU 9479, I/A 50 ( 4.07.19).
09 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AVANZA CERCANIAS MADRID SL. Nombramientos. Adm. Mancom.: ALONSO SOROAVALENTIN;DURAN REGIS MARTHA ANGELICA;ROMAN SANCHEZ-RUBIO JOSE LUIS. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 631 , F 169, S 8, H HU 9479, I/A 49 (2.04.19).
07 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO SOROA VALENTIN;LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON. Apoderado: NOGUERAS BRAVOISABEL;LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON. Apo.Manc.: ALONSO SOROA VALENTIN;LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON.Apo.Man.Soli: ARIAS LOPEZ JUAN ABEL;ORNELAS VALLE IRMA GUADALUPE. Apo.Sol.: PARRA LOPEZ CARLOSMARIA;TOLOSANA COLLADO MARIA BLANCA. Datos registrales. T 631 , F 169, S 8, H HU 9479, I/A 48 (31.01.19).
07 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 631 , F 169, S 8, H HU 9479, I/A 47 (31.10.18).
16 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: DURAN REGIS MARTHA ANGELICA. Datos registrales. T 631 , F 166, S 8, H HU 9479, I/A 45 (8.05.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: HIDALGO SALCEDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 631 , F 168, S 8, H HU 9479, I/A 46 ( 8.05.18).
01 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ MIGUEL PATRICIA. Datos registrales. T 631 , F 164, S 8, H HU 9479, I/A 44 (25.01.18).
26 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 631 , F 164, S 8, H HU 9479, I/A 42 (18.12.17).
Otros conceptos: MODIFICADOS en su totalidad los Estatutos Sociales, incluyendo la Modificaci贸n del Objeto Social y de laRetribuci贸n del Organo de Administraci贸n. Cambio de objeto social. a) La prestaci贸n y explotaci贸n servicios p煤blicos y privados detransportes de viajeros de cualquier naturaleza, modo o clase, regulares, discrecionales y especiales, urbanos e interurbanos. b) Laexplotaci贸n de estaciones de autobuses, intercambiadores de transporte, centros de distribuci贸n de merc. Datos registrales. T 631 , F164, S 8, H HU 9479, I/A 43 (18.12.17).
08 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON;NOGUERAS BRAVO ISABEL;SOLANES ENJUANES FRANCISCOJAVIER. Apo.Manc.: LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON;NOGUERAS BRAVO ISABEL;SOLANES ENJUANES FRANCISCOJAVIER. Apo.Sol.: LOPEZ PEREZ JORGE;MOLINER BURREL JUAN JOSE. Apo.Manc.: MOLINER BURREL JUAN JOSE.Apoderado: MERCADO GOMEZ WILFRIDO;GONZALEZ LOZANO LIGIA CLAUDIA;LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO Datosregistrales. T 631 , F 163, S 8, H HU 9479, I/A 41 ( 2.11.17).
17 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: ARIAS LOPEZ JUAN ABEL. Datos registrales. T 631 , F 162, S 8, H HU 9479, I/A 40 ( 9.08.17).
03 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: DUPERIER PRADO ARTURO JAVIER. Datos registrales. T 631 , F 160, S 8, H HU 9479, I/A 37(27.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: HERREROS SIERRA JOSE MARIA. Datos registrales. T 631 , F 160, S 8, H HU 9479, I/A 38 (27.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ MIGUEL PATRICIA. Datos registrales. T 631 , F 161, S 8, H HU 9479, I/A 39 (27.07.17).
05 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: TOLOSANA COLLADO MARIA BLANCA. Fe de erratas: La fecha correcta del poder conferido a donCarlos Mar铆a Parra L贸pez en la inscripci贸n 35陋 es 08 de Julio de 2.016, siendo de car谩cter SOLIDARIO. Datos registrales. T 631 , F159, S 8, H HU 9479, I/A 35 ( 3.08.16).
10 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORNELAS VALLE IRMA GUADALUPE. Datos registrales. T 619 , F 5, S 8, H HU 9479, I/A 24 (3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO SOROA VALENTIN. Datos registrales. T 619 , F 8, S 8, H HU 9479, I/A 26 ( 3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 619 , F 10, S 8, H HU 9479, I/A 27 (3.08.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ LUNA SILVIA. Datos registrales. T 619 , F 7, S 8, H HU 9479, I/A 25 ( 3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 631 , F 151, S 8, H HU 9479, I/A 28 (3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ DE DIEGO ELOISA. Datos registrales. T 631 , F 153, S 8, H HU 9479, I/A 29 ( 3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA DE LEANIZ CANOSA IGNACIO CESAR. Datos registrales. T 631 , F 154, S 8, H HU9479, I/A 30 ( 3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ FERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 631 , F 155, S 8, H HU 9479, I/A 31 (3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOLINER BURREL JUAN JOSE. Datos registrales. T 631 , F 156, S 8, H HU 9479, I/A 32 (3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NOGUERAS BRAVO ISABEL;DOMINGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO;PEREZ MARTINEZJOSE MANUEL. Datos registrales. T 631 , F 157, S 8, H HU 9479, I/A 33 ( 3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PASTOR ANTONIO. Datos registrales. T 631 , F 158, S 8, H HU 9479, I/A 34 ( 3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARRA LOPEZ CARLOS MARIA. Datos registrales. T 631 , F 159, S 8, H HU 9479, I/A 35 (3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TRIGUEROS RODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 631 , F 159, S 8, H HU 9479, I/A 36 (3.08.16).
29 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO SOROA VALENTIN;LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO. Presidente: ALONSO SOROAVALENTIN. Consejero: LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON. SecreNoConsj: HERREROS SIERRA JOSE MARIA. Nombramientos.Adm. Unico: AVANZA CERCANIAS MADRID SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 619 , F 5, S 8, H HU 9479, I/A 23 (18.01.16).
10 de Agosto de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARIAS LOPEZ JUAN ABEL. Datos registrales. T 588 , F 122, S 8, H HU 9479, I/A 22 ( 4.08.15).
21 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: NOGUERAS BRAVO ISABEL;LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 588 , F 122,S 8, H HU 9479, I/A 20 (15.07.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO SOROA VALENTIN;LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON. Apo.Manc.: ALONSO SOROAVALENTIN;LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 588 , F 122, S 8, H HU 9479, I/A 21 (15.07.15).
08 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN-RETORTILLO LEGUINA PABLO. Revocaciones. Apoderado: MARTIN-RETORTILLOLEGUINA PABLO. Apo.Manc.: MU脩OZ SANZ HECTOR. Apoderado: MU脩OZ SANZ HECTOR. Apo.Sol.: MU脩OZ SANZ HECTOR.Nombramientos. Consejero: LASIERRA ARASANZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 588 , F 121, S 8, H HU 9479, I/A 19 (1.07.15).
31 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ LOZANO LIGIA CLAUDIA. Datos registrales. T 588 , F 120, S 8, H HU 9479, I/A 17(25.03.15).
Nombramientos. Apoderado: LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 588 , F 121, S 8, H HU 9479, I/A 18(25.03.15).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ ANTON JOSE ANTONIO;URIARTE AMANN JUAN CARLOS;PEREZ ALONSOAURELIO;MERCADO GOMEZ WILFRIDO. Datos registrales. T 588 , F 119, S 8, H HU 9479, I/A 16 (25.03.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS. Presidente: LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS.Revocaciones. Apoderado: LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS. Nombramientos. Consejero: LOZANO BONFIL LUISFERNANDO. Presidente: ALONSO SOROA VALENTIN. Datos registrales. T 588 , F 119, S 8, H HU 9479, I/A 15 (25.03.15).
19 de Noviembre de 2014Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos.Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 588 , F 118, S 8, H HU 9479, I/A 14 (13.11.14).
01 de Julio de 2013Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: AVANZA CERCANIAS MADRID SL. Datos registrales. T 588 , F118, S 8, H HU 9479, I/A 12 (24.06.13).
Otros conceptos: Modificaci贸n de los Art铆culos 6潞 y 9潞 de los Estatutos Sociales, relativos a la transmisi贸n de las participacionessociales. Datos registrales. T 588 , F 118, S 8, H HU 9479, I/A 13 (24.06.13).
09 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 588 , F 118, S 8, H HU 9479, I/A 11(28.12.11).
22 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: MOLINER BURREL JUAN JOSE. Apo.Manc.: MOLINER BURREL JUAN JOSE. Datos registrales. T 549, F 225, S 8, H HU 9479, I/A 10 (13.12.11).
11 de Agosto de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ FERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO. Datos registrales. T 549 , F 225, S 8, H HU 9479,I/A 9 ( 2.08.11).
21 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO. Apo.Manc.: FERNANDEZ FERNANDEZ HECTORALEJANDRO. Datos registrales. T 549 , F 223, S 8, H HU 9479, I/A 8 (11.02.11).
04 de Octubre de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ PEREZ JORGE. Datos registrales. T 549 , F 223, S 8, H HU 9479, I/A 7 (24.09.10).
05 de Enero de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ PEREZ JORGE. Apo.Manc.: LOPEZ PEREZ JORGE. Datos registrales. T 549 , F 222, S 8, HHU 9479, I/A 6 (24.12.09).
22 de Abril de 2009Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 549 , F 222, S 8, H HU 9479, I/A5 (13.04.09).