Actos BORME de Alpstar Spain Sl
15 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BRAVARD NICOLAS;PINEL BERTRAND. Presidente: BRAVARD NICOLAS. Con.Delegado:BRAVARD NICOLAS. Consejero: RIVARA PIERRE LAURENT BRUNO PAOLO JEAN. Secretario: BULNES FERNANDEZMAZARAMBROZ ANTONIO ENRIQUE. VsecrNoConsj: PE脩ALOSA PITA LUCIA. Vsecr1.NC: MARTIN GIL BELEN. Nombramientos.Liquidador: FIGUEROA MEZQUITA ENRIQUE ANTONIO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 29043 , F 151, S8, H M 485183, I/A 14 ( 4.01.18).
17 de Junio de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: RIENDA ROCA JUAN JOSE;ACIEN SANCHEZ PEDRO. Nombramientos. Apoderado: MARTIN GILBELEN;PINEL BERTRAND ROGER MARIA. Datos registrales. T 29043 , F 150, S 8, H M 485183, I/A 13 (10.06.13).
14 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIALES REGORDAN MANUEL. Vicepresid.: RUBIALES REGORDAN MANUEL.Nombramientos. Consejero: RIVARA PIERRE LAURENT BRUNO PAOLO JEAN. Datos registrales. T 29043 , F 149, S 8, H M485183, I/A 12 ( 6.06.13).
16 de Julio de 2012Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DMF PARTNERS HOLDING SA. Datos registrales. T 29043 , F 149, S 8, H M485183, I/A 11 ( 5.07.12).
24 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: RIENDA ROCA JUAN JOSE;ACIEN SANCHEZ PEDRO. Datos registrales. T 26924 , F 36, S 8, HM 485183, I/A 10 (11.01.12).
05 de Enero de 2012Revocaciones. Apoderado: NAVARRO ESTEVEZ ANDRES;NAVARRO ESTEVEZ ANDRES. Datos registrales. T 26924 , F 36, S 8,H M 485183, I/A 9 (26.12.11).
12 de Diciembre de 2011Nombramientos. Vsecr1.NC: MARTIN GIL BELEN. Datos registrales. T 26924 , F 36, S 8, H M 485183, I/A 8 (28.11.11).
05 de Noviembre de 2010Cambio de domicilio social. PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1 - PARQUE EMPRESARIAL LA (POZUELO DE ALARCON). Datosregistrales. T 26924 , F 35, S 8, H M 485183, I/A 6 (25.10.10).
09 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUBIALES REGORDAN MANUEL. Nombramientos. Consejero: RUBIALES REGORDANMANUEL;BRAVARD NICOLAS;PINEL BERTRAND. Presidente: BRAVARD NICOLAS. Vicepresid.: RUBIALES REGORDAN MANUEL.SecreNoConsj: BULNES FERNANDEZ MAZARAMBROZ ANTONIO ENRIQUE. VsecrNoConsj: PE脩ALOSA PITA LUCIA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n.SE
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO ESTEVEZ ANDRES. Datos registrales. T 26924 , F 34, S 8, H M 485183, I/A 3 (26.11.09).
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO ESTEVEZ ANDRES. Datos registrales. T 26924 , F 35, S 8, H M 485183, I/A 4 (26.11.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: PINEL BERTRAND ROGER MARIA;BRUNO PAOLO JEAN JEAN PIERRE LAURENT. Datosregistrales. T 26924 , F 35, S 8, H M 485183, I/A 5 (26.11.09).
Nombramientos. Con.Delegado: BRAVARD NICOLAS. Datos registrales. T 26924 , F 33, S 8, H M 485183, I/A 2 (26.11.09).
13 de Agosto de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.04.09. Objeto social: ASESORAMIENTO SOBRE OPERACIONES DE FUSION YADQUISICION, BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE INVERSION, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE NEGOCIO EINTEGRACION CON OTRAS RAMAS DE NEGOCIO... Domicilio: C/ JAZMIN 1 (POZUELO DE ALARCON). Capital: 3.006,00 Euros.Nombramientos. Adm. Unico: RUBIALES REGORDAN MANUEL. Datos registrales. T 26924 , F 27, S 8, H M 485183, I/A 1 (4.08.09).