Buscador CIF Logo

Actos BORME Alpstar Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Alpstar Spain Sl

Actos BORME Alpstar Spain Sl - B85684272

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Alpstar Spain Sl con CIF B85684272

馃敊 Perfil de Alpstar Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Alpstar Spain Sl

15 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRAVARD NICOLAS;PINEL BERTRAND. Presidente: BRAVARD NICOLAS. Con.Delegado:BRAVARD NICOLAS. Consejero: RIVARA PIERRE LAURENT BRUNO PAOLO JEAN. Secretario: BULNES FERNANDEZMAZARAMBROZ ANTONIO ENRIQUE. VsecrNoConsj: PE脩ALOSA PITA LUCIA. Vsecr1.NC: MARTIN GIL BELEN. Nombramientos.Liquidador: FIGUEROA MEZQUITA ENRIQUE ANTONIO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 29043 , F 151, S8, H M 485183, I/A 14 ( 4.01.18).

17 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RIENDA ROCA JUAN JOSE;ACIEN SANCHEZ PEDRO. Nombramientos. Apoderado: MARTIN GILBELEN;PINEL BERTRAND ROGER MARIA. Datos registrales. T 29043 , F 150, S 8, H M 485183, I/A 13 (10.06.13).

14 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIALES REGORDAN MANUEL. Vicepresid.: RUBIALES REGORDAN MANUEL.Nombramientos. Consejero: RIVARA PIERRE LAURENT BRUNO PAOLO JEAN. Datos registrales. T 29043 , F 149, S 8, H M485183, I/A 12 ( 6.06.13).

16 de Julio de 2012
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DMF PARTNERS HOLDING SA. Datos registrales. T 29043 , F 149, S 8, H M485183, I/A 11 ( 5.07.12).

24 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RIENDA ROCA JUAN JOSE;ACIEN SANCHEZ PEDRO. Datos registrales. T 26924 , F 36, S 8, HM 485183, I/A 10 (11.01.12).

05 de Enero de 2012
Revocaciones. Apoderado: NAVARRO ESTEVEZ ANDRES;NAVARRO ESTEVEZ ANDRES. Datos registrales. T 26924 , F 36, S 8,H M 485183, I/A 9 (26.12.11).

12 de Diciembre de 2011
Nombramientos. Vsecr1.NC: MARTIN GIL BELEN. Datos registrales. T 26924 , F 36, S 8, H M 485183, I/A 8 (28.11.11).

05 de Noviembre de 2010
Cambio de domicilio social. PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1 - PARQUE EMPRESARIAL LA (POZUELO DE ALARCON). Datosregistrales. T 26924 , F 35, S 8, H M 485183, I/A 6 (25.10.10).

09 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUBIALES REGORDAN MANUEL. Nombramientos. Consejero: RUBIALES REGORDANMANUEL;BRAVARD NICOLAS;PINEL BERTRAND. Presidente: BRAVARD NICOLAS. Vicepresid.: RUBIALES REGORDAN MANUEL.SecreNoConsj: BULNES FERNANDEZ MAZARAMBROZ ANTONIO ENRIQUE. VsecrNoConsj: PE脩ALOSA PITA LUCIA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n.SE

Nombramientos. Apoderado: NAVARRO ESTEVEZ ANDRES. Datos registrales. T 26924 , F 34, S 8, H M 485183, I/A 3 (26.11.09).

Nombramientos. Apoderado: NAVARRO ESTEVEZ ANDRES. Datos registrales. T 26924 , F 35, S 8, H M 485183, I/A 4 (26.11.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: PINEL BERTRAND ROGER MARIA;BRUNO PAOLO JEAN JEAN PIERRE LAURENT. Datosregistrales. T 26924 , F 35, S 8, H M 485183, I/A 5 (26.11.09).

Nombramientos. Con.Delegado: BRAVARD NICOLAS. Datos registrales. T 26924 , F 33, S 8, H M 485183, I/A 2 (26.11.09).

13 de Agosto de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.04.09. Objeto social: ASESORAMIENTO SOBRE OPERACIONES DE FUSION YADQUISICION, BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE INVERSION, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE NEGOCIO EINTEGRACION CON OTRAS RAMAS DE NEGOCIO... Domicilio: C/ JAZMIN 1 (POZUELO DE ALARCON). Capital: 3.006,00 Euros.Nombramientos. Adm. Unico: RUBIALES REGORDAN MANUEL. Datos registrales. T 26924 , F 27, S 8, H M 485183, I/A 1 (4.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n