Actos BORME de Alsa Metropolitana Sa
07 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: LLANA GONZALEZ JOSE CESAR. Datos registrales. T 40016 , F 161, S 8, H M 365210, I/A 35(31.07.23).
06 de Junio de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40016 , F 161, S 8, H M 365210, I/A 34 (30.05.22).
08 de Marzo de 2022Cambio de domicilio social. C/ JOSEFA VALCARCEL 20 (MADRID). Datos registrales. T 40016 , F 161, S 8, H M 365210, I/A 33 (1.03.22).
02 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ BAÑUELOS JUAN ANTONIO;DIAZ SUAREZ DAVID. Datos registrales. T 40016 , F 160, S 8, HM 365210, I/A 32 (25.06.21).
02 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40016 , F 160, S 8, H M 365210, I/A 31 (23.02.21).
29 de Julio de 2020Reelecciones. Representan: LOPEZ MENENDEZ VICTOR-MANUEL;GARCIA HIDALGO MARCOS. Adm. Mancom.: EBROBUSSL;PROYECTOS UNIFICADOS SA. Datos registrales. T 40016 , F 160, S 8, H M 365210, I/A 30 (22.07.20).
26 de Junio de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: PARRONDO GONZALEZ MANUEL EDUARDO. Nombramientos. Representan: GARCIAHIDALGO MARCOS. Datos registrales. T 20628 , F 171, S 8, H M 365210, I/A 29 (19.06.20).
13 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: CEREIJO ALIJOSTES MARINA. Datos registrales. T 20628 , F 171, S 8, H M 365210, I/A 28 (6.05.19).
15 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: TRANSPORTES UNIDOS SL. Representan: GONZALEZ HERNADEZ RAFAEL JUAN.Nombramientos. Representan: LOPEZ MENENDEZ VICTOR-MANUEL. Adm. Mancom.: PROYECTOS UNIFICADOS SA. Datosregistrales. T 20628 , F 170, S 8, H M 365210, I/A 27 ( 6.03.18).
17 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20628 , F 170, S 8, H M 365210, I/A 26 ( 9.01.18).
24 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS CAMPOS FRANCISCO. Datos registrales. T 20628 , F 168, S 8, H M 365210, I/A 23(16.02.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SANCHEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 20628 , F 169, S 8, H M 365210, I/A 24(16.02.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARBAJO DE LA FUENTE FRANCISCO JAVIER. Apoderado: CARBAJO DE LA FUENTEFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 20628 , F 170, S 8, H M 365210, I/A 25 (16.02.17).
04 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: LOPEZ MENENDEZ VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 20628 , F 167, S 8, H M 365210, I/A 22(26.10.16).
05 de Agosto de 2015Reelecciones. Representan: GONZALEZ HERNADEZ RAFAEL JUAN;PARRONDO GONZALEZ MANUEL EDUARDO. Adm.Mancom.: TRANSPORTES UNIDOS SL;EBROBUS SL. Datos registrales. T 20628 , F 167, S 8, H M 365210, I/A 21 (28.07.15).
19 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIO VAQUERIZO OSCAR. Datos registrales. T 20628 , F 164, S 8, H M 365210, I/A 20 (8.05.15).
01 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20628 , F 164, S 8, H M 365210, I/A 19 (21.11.14).
18 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDO SANCHEZ VICTOR. Datos registrales. T 20628 , F 163, S 8, H M 365210, I/A 18(11.06.14).
27 de Diciembre de 2013Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 478 (MADRID). Datos registrales. T 20628 , F 162, S 8, H M 365210, I/A 17 (17.12.13).
01 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: GAMEZ CARMONA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 20628 , F 162, S 8, H M 365210, I/A 16(21.11.11).
17 de Octubre de 2011Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 20628 , F 162, S 8, H M 365210, I/A 15 ( 4.10.11).
29 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: CAO INTRIAGO FRANCISCO;VAZQUEZ FERNANDEZ SANDRA. Datos registrales. T 20628 , F 161,S 8, H M 365210, I/A 14 (10.08.11).
27 de Septiembre de 2010Reelecciones. Adm. Mancom.: TRANSPORTES UNIDOS SL;EBROBUS SL. Representan: GONZALEZ HERNANDEZ RAFAELJUAN;PARRONDO GONZALEZ MANUEL EDUARDO. Datos registrales. T 20628 , F 161, S 8, H M 365210, I/A 13 (15.09.10).
14 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20628 , F 161, S 8, H M 365210, I/A 12 (30.12.08).