Actos BORME de Alsamasa Construcciones Sl
24 de Noviembre de 2023Revocaciones. AUDIT.CUENT.: PKF AUDIEC SAP. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GINESTA ALBERT CARLOS. Datosregistrales. T 41192 , F 67, S 8, H B 306687, I/A 26 (16.11.23).
28 de Agosto de 2023Revocaciones. APODERAD.SOL: COSTA PONS JOAQUIM. Nombramientos. APODERAD.SOL: NOVENSA RUEDA OLGA.Datos registrales. T 41192 , F 67, S 8, H B 306687, I/A 25 (21.08.23).
20 de Julio de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTINEZ PRIETO MARIA ASUNCION;COSTA PONS JOAQUIM. Datos registrales. T 41192, F 66, S 8, H B 306687, I/A 24 (11.07.23).
11 de Abril de 2023Revocaciones. APOD.SOL/MAN: RAMIREZ AGUERO JUAN;SANTOS LOPEZ OSCAR;BONDIA MARTINEZ OSCAR. Datosregistrales. T 41192 , F 66, S 8, H B 306687, I/A 23 (30.03.23).
22 de Marzo de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 140.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 280.000,00 Euros. Datos registrales. T 41192 , F66, S 8, H B 306687, I/A 22 (13.03.23).
15 de Marzo de 2023Revocaciones. CONSEJERO: RAMIREZ AGUERO JUAN;SANTOS LOPEZ OSCAR. SECRETARIO: RAMIREZ AGUERO JUAN.CONSEJERO: BONDIA MARTINEZ OSCAR. CONS.DEL.MAN: BONDIA MARTINEZ OSCAR;SANTOS LOPEZ OSCAR;RAMIREZAGUERO JUAN. PRESIDENTE: SANTOS LOPEZ OSCAR. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: SANTOS LOPEZ OSCAR;BONDIAMARTINEZ OSCAR. Datos registrales. T 41192 , F 66, S 8, H B 306687, I/A 21 ( 8.03.23).
25 de Enero de 2022Revocaciones. APODERAD.SOL: RAMIREZ AGUERO JUAN. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: RAMIREZ AGUEROJUAN;SANTOS LOPEZ OSCAR;BONDIA MARTINEZ OSCAR. Datos registrales. T 41192 , F 65, S 8, H B 306687, I/A 20 (18.01.22).
07 de Enero de 2022Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PKF AUDIEC SAP. Datos registrales. T 41192 , F 65, S 8, H B 306687, I/A 19 (28.12.21).
04 de Febrero de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 120.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 420.000,00 Euros. Datos registrales. T 41192 , F 64, S 8, HB 306687, I/A 18 (27.01.20).
16 de Diciembre de 2019Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PKF AUDIEC SAP. Datos registrales. T 41192 , F 64, S 8, H B 306687, I/A 17 ( 4.12.19).
16 de Mayo de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: RAMIREZ AGUERO JUAN. Datos registrales. T 41192 , F 63, S 8, H B 306687, I/A 16 (5.05.17).
02 de Marzo de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros. Datos registrales. T 41192 , F 63, S 8, HB 306687, I/A 15 (22.02.17).
13 de Julio de 2016Modificaciones estatutarias. ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 41192 , F 62, S 8, H B 306687, I/A 14 ( 6.07.16).
12 de Agosto de 2014Revocaciones. CONSEJERO: FIGUERAS QUESADA MANUEL. PRESIDENTE: FIGUERAS QUESADA MANUEL. Nombramientos.CONSEJERO: BONDIA MARTINEZ OSCAR. CONS.DEL.MAN: BONDIA MARTINEZ OSCAR;SANTOS LOPEZ OSCAR;RAMIREZAGUERO JUAN. PRESIDENTE: SANTOS LOPEZ OSCAR. Datos registrales. T 41192 , F 62, S 8, H B 306687, I/A 13 ( 4.08.14).
09 de Mayo de 2013Revocaciones. APODERADO: PELEJA MARTI MERCEDES. Datos registrales. T 41192 , F 62, S 8, H B 306687, I/A 12 (29.04.13).
16 de Abril de 2013Revocaciones. CONSEJERO: GATELL GOMEZ ALEJANDRO. APODERADO: GATELL GOMEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T41192 , F 62, S 8, H B 306687, I/A 11 ( 9.04.13).
17 de Marzo de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 196.900,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros. Datos registrales. T 41192 , F 61, S 8, HB 306687, I/A 10 ( 3.03.11).
26 de Mayo de 2009Cambio de domicilio social. CL IGNASI IGLESIAS, NUM.19, LOCAL 3-4 (CORNELLA DE LLOBREGAT). Datos registrales. T37635 , F 68, S 8, H B 306687, I/A 9 (13.05.09).