Actos BORME de Altair Asesores Sl
14 de Marzo de 2022Modificaciones estatutarias. HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 19º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA LAINCLUSION DE LA POSIBILIDAD DE LA CELEBRACION DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS POR MEDIOSTELEMATICOS.-. Datos registrales. T 14231 , F 218, S 8, H M 2685, I/A 26 ( 7.03.22).
17 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: VALLDAURA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 14231 , F 218, S 8, H M 2685, I/A 25 (10.01.22).
05 de Octubre de 2021Cambio de domicilio social. C/ MIGUEL ANGEL 4 - BAJO 14 (MADRID). Datos registrales. T 14231 , F 218, S 8, H M 2685, I/A 24(28.09.21).
12 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: VIVANCOS BAÑOS ANTONIO;VIVANCOS FERNANDEZ BUGALLAL BLANCA;VIVANCOS FERNANDEZBUGALLAL IGNACIO;VIVANCOS FERNANDEZ-BUGALLAL RAFAEL-JOSE. Datos registrales. T 14231 , F 218, S 8, H M 2685, I/A23 ( 5.07.21).
06 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: VIVANCOS BAÑOS ANTONIO;FERNANDEZ BUGALLAL LORENZO MARIA CRISTINA;VIVANCOSFERNANDEZ BUGALLAL BLANCA. Con.Delegado: VIVANCOS BAÑOS ANTONIO. Consejero: VIVANCOS FERNANDEZ BUGALLALIGNACIO. Presidente: VIVANCOS BAÑOS ANTONIO. Vicepresid.: VIVANCOS FERNANDEZ BUGALLAL BLANCA. SecreNoConsj:BAÑOS PITA JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: VIVANCOS BAÑOS ANTONIO. Otros conceptos: Cambio del Organode Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 14231 , F 217, S 8, H M 2685, I/A 22(29.06.21).
26 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: VIVANCOS FERNANDEZ-BUGALLAL RAFAEL-JOSE. Secretario: VIVANCOS FERNANDEZ-BUGALLAL RAFAEL-JOSE. Presidente: FERNANDEZ BUGALLAL LORENZO MARIA CRISTINA. Revocaciones. Apoderado:UREÑA DE LA TORRE DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: BAÑOS PITA JOSE MARIA. Consejero: VIVANCOS FERNANDEZBUGALLAL IGNACIO. Presidente: VIVANCOS BAÑOS ANTONIO. Vicepresid.: VIVANCOS FERNANDEZ BUGALLAL BLANCA.Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 18 y 26 de los estatutos sociales . Datos registrales. T 14231 , F 216, S 8, HM 2685, I/A 21 (19.02.21).
10 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: VALLDAURA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 14231 , F 216, S 8, H M 2685, I/A 20 ( 3.10.19).
12 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: VIVANCOS FERNANDEZ BUGALLAL BLANCA;VIVANCOS FERNANDEZ BUGALLALIGNACIO;VIVANCOS FERNANDEZ-BUGALLAL RAFAEL-JOSE. Datos registrales. T 14231 , F 215, S 8, H M 2685, I/A 19 ( 3.01.18).
26 de Septiembre de 2016Nombramientos. Auditor: VALLDAURA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 14231 , F 215, S 8, H M 2685, I/A 18 (16.09.16).
09 de Septiembre de 2015Otros conceptos: SUBSANACION DE LA INSCRIPCION 16& EN CUANTO AL DNI DE LA APODERADA DOÑA MARIA CRISTINAFERNANDEZ BUGALLAL, SIENDO EL CORRECTO 364336-Q. Datos registrales. T 14231 , F 214, S 8, H M 2685, I/A 17 ( 2.09.15).
09 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-BUGALLAL LORENZO MARIA-CRISTINA. Datos registrales. T 14231 , F 214, S 8, H M2685, I/A 16 (31.03.15).
31 de Octubre de 2013Cambio de domicilio social. C/ MARIA DE MOLINA 1 5º - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 14231 , F 213, S 8, H M2685, I/A 15 (23.10.13).
05 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: UREÑA DE LA TORRE DAVID. Datos registrales. T 14231 , F 213, S 8, H M 2685, I/A 14 (23.11.11).
24 de Junio de 2011Cambio de domicilio social. C/ GENOVA NUMERO 21, 4º DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 14231 , F 213, S 8, H M2685, I/A 13 (14.06.11).
04 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: CIENFUEGOS GONZALEZ ARANZAZU. Datos registrales. T 14231 , F 213, S 8, H M 2685, I/A 12(26.07.10).