Actos BORME de Alto Social Analytics Sl
24 de Noviembre de 2023Cambio de domicilio social. C/ ACANTO 22 7 (MADRID). Datos registrales. T 39081 , F 129, S 8, H M 434865, I/A 22 (17.11.23).
Revocaciones. Apoderado: SANZ PINTO HERMINIA. Datos registrales. T 39081 , F 130, S 8, H M 434865, I/A 23 (17.11.23).
17 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ MARTIN PEDRO. Consejero: GOMEZ ARREAZA ALBERTO. Presidente: YEPEZJUAN ALBERTO. Consejero: YEPEZ JUAN ALBERTO. Nombramientos. Adm. Solid.: GOYARROLA QUERALT JAIME;KUMMETZERIC. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 39081 , F 129, S 8, H M 434865, I/A 21 (10.04.23).
04 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO GALLEGO ALEJANDRO. Con.Delegado: ROMERO GALLEGO ALEJANDRO. Datosregistrales. T 39081 , F 129, S 8, H M 434865, I/A 20 (28.12.22).
03 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: AMBWANI KAILASH;AMBWANI KAILASH. Nombramientos. Apoderado: CASAL MARTIN JULIO.
21 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: AMBWANI KAILASH. Datos registrales. T 39081 , F 126, S 8, H M 434865, I/A 16 (14.11.22).
Nombramientos. Apoderado: SANZ PINTO HERMINIA. Datos registrales. T 39081 , F 126, S 8, H M 434865, I/A 17 (14.11.22).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MARTIN PEDRO ANTONIO;CARLOS RUBIO BREMARD;CARNERO CUENCAIGNACIO;FABIO CESAR CAMACHO URQUIDI. Datos registrales. T 39081 , F 127, S 8, H M 434865, I/A 18 (14.11.22).
22 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: GOYARROLA QUERALT JAIME;KUMMETZ ERIC;AMBWANI KAILASH. Datos registrales. T 39081 ,F 124, S 8, H M 434865, I/A 15 (15.06.22).
29 de Septiembre de 2021Nombramientos. Auditor: ALESCO PARTNERS SLP. Cambio de domicilio social. C/ ACANTO 22, PLANTA 13 (MADRID). Datosregistrales. T 39081 , F 123, S 8, H M 434865, I/A 14 (22.09.21).
29 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROMERO GALLEGO ALEJANDRO. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ MARTINPEDRO. Consejero: GOMEZ ARREAZA ALBERTO;YEPEZ JUAN ALBERTO;ROMERO GALLEGO ALEJANDRO. Presidente: YEPEZJUAN ALBERTO. Con.Delegado: ROMERO GALLEGO ALEJANDRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 39081 , F 122, S 8, H M 434865, I/A 13 (21.12.20).
28 de Diciembre de 2020Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: 4IQ INC. Datos registrales. T 39081 , F 122, S 8, H M 434865, I/A 12 (18.12.20).
12 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: GALVEZ DEL RIO MARIA MERCEDES;GOYARROLA QUERALT JAIME. Datos registrales. T 39081 , F122, S 8, H M 434865, I/A 11 ( 4.11.20).
18 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: GOYARROLA QUERALT JAIME. Datos registrales. T 24201 , F 95, S 8, H M 434865, I/A 10(11.06.19).
14 de Diciembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 155,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.005,00 Euros. Datos registrales. T 24201 , F 94, S8, H M 434865, I/A 9 ( 4.12.17).
01 de Diciembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 150,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.160,00 Euros. Datos registrales. T 24201 , F 93, S 8, H M434865, I/A 8 (23.11.17).
29 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: GALVEZ DEL RIO MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 24201 , F 92, S 8, H M 434865, I/A 7(18.12.15).
28 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GALVEZ DEL RIO MARIA MERCEDES. Nombramientos. Adm. Unico: ROMERO GALLEGOALEJANDRO. Modificaciones estatutarias. 25. Administraci贸n y Representacion.- Retribuci贸n de los administradores.. Datosregistrales. T 24201 , F 91, S 8, H M 434865, I/A 6 (17.12.15).