Actos BORME de Altos De Benferri Sl
02 de Diciembre de 2021Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 160/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 6/10/2021. Auto de conclusi贸n delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE. Juez:JOSE LUIS FORTEA GORBE. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 160/2014. Fecha de resoluci贸n 21/03/2014.Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: LUIS SELLER ROCA DETOGORES. Administrador Concursal. Fecha 6/10/2021, NIF/CIF B73820524. ABP INSOLVENCIAS SLP. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 160/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 6/10/2021. Cese de las limitaciones de las facultades deadministraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE. Juez: JOSE LUIS FORTEA GORBE.Extinci贸n. Datos registrales. T 2275 , F 110, S 8, H A 55759, I/A 11 (24.11.21).
08 de Mayo de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 160/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 21/03/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: LUIS SELLER ROCA DE TOGORES. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 160/2014. Fecha de resoluci贸n 21/03/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 3DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: LUIS SELLER ROCA DE TOGORES. Administrador Concursal. Fecha 21/03/2014, NIF/CIFB73820524. ABP INSOLVENCIAS SLP. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 160/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n21/03/2014. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado.Juzgado: num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. Juez: LUIS SELLER ROCA DE TOGORES. Datos registrales. T 2275 , F 39, S8, H A 55759, I/A 9 (29.04.14).
08 de Octubre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: DURAN HERNANDEZ-MORA JOSE LUIS;FERNANDEZ DELGADO ROMERO RAFAEL;MATIAS PLAZAJUAN;RODRIGUEZ MARTIN MANUEL;JUAN JIMENEZ AGUSTIN;MATIAS PLAZA JUAN;RODRIGUEZ MARTIN MANUEL;PEREZALONSO PEDRO MANUEL;DURAN HERNANDEZ-MORA JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: DURAN HERNANDEZ-MORAJOSE LUIS;MATIAS PLAZA JUAN. Datos registrales. T 2275 , F 39, S 8, H A 55759, I/A 8 ( 2.10.13).
11 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN JIMENEZ AGUSTIN;RODRIGUEZ MARTIN MANUEL;DURAN HERNANDEZ-MORA JOSELUIS;MATIAS PLAZA JUAN;PEREZ ALONSO PEDRO MANUEL. Presidente: JUAN JIMENEZ AGUSTIN. Secretario: RODRIGUEZMARTIN MANUEL. Vicesecret.: DURAN HERNANDEZ-MORA JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ MARTINMANUEL;DURAN HERNANDEZ-MORA JOSE LUIS;MATIAS PLAZA JUAN;PEREZ ALONSO PEDRO MANUEL. Presidente: DURANHERNANDEZ-MORA JOSE LUIS. Secretario: MATIAS PLAZA JUAN. Datos registrales. T 2275 , F 39, S 8, H A 55759, I/A 7 (4.09.13).
11 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ DELGADO ROMERO RAFAEL. Vicepresid.: FERNANDEZ DELGADO ROMERORAFAEL. Datos registrales. T 2275 , F 39, S 8, H A 55759, I/A 6 (30.05.12).
30 de Septiembre de 2011Nombramientos. Vicepresid.: FERNANDEZ DELGADO ROMERO RAFAEL. Vicesecret.: DURAN HERNANDEZ MORA JOSE LUIS.Cambio de domicilio social. AVDA TEODOMIRO 56 ENTRESUE (ORIHUELA). Datos registrales. T 2275 , F 38, S 8, H A 55759,I/A 5 (20.09.11).
24 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JUAN JIMENEZ AGUSTIN. Nombramientos. Consejero: JUAN JIMENEZ AGUSTIN;RODRIGUEZMARTIN MANUEL;FERNANDEZ DELGADO ROMERO RAFAEL;DURAN HERNANDEZ MORA JOSE LUIS;MATIAS PLAZAJUAN;PEREZ ALONSO PEDRO MANUEL. Presidente: JUAN JIMENEZ AGUSTIN. Secretario: RODRIGUEZ MARTIN MANUEL.Apo.Manc.: JUAN JIMENEZ AGUSTIN;MATIAS PLAZA JUAN;RODRIGUEZ MARTIN MANUEL;PEREZ ALONSO PEDROMANUEL;DURAN HERNANDEZ MORA JOSE LUIS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 2275 , F 37, S 8, H A 55759, I/A 4 (14.07.09).
08 de Enero de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 2275 , F 37, S 8, HA 55759, I/A 3 (23.12.08).