Actos BORME de Alvac Sa
17 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: JOSE LUIS RUBIO PEREA. Datos registrales. T 305 , F 125, S 8, H SG 382, I/A 116 (10.11.23).
03 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: LAURA NUEZ GONZALVO. Datos registrales. T 305 , F 124, S 8, H SG 382, I/A 114 (26.09.23).
Nombramientos. Apoderado: ALBERTO REY LOPEZ. Datos registrales. T 305 , F 124, S 8, H SG 382, I/A 115 (26.09.23).
28 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO GARCIA LOPEZ. Datos registrales. T 305 , F 123, S 8, H SG 382, I/A 113 (21.03.23).
04 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: VALDECANTOS MONTES JESUS. Apo.Sol.: ROBERTO YANEZ CA脩AMARES. Apoderado: ROBERTOYANEZ CA脩AMARES. Apo.Sol.: ANDRES BARCENA GONZALEZ;ANDRES BARCENA GONZALEZ;JUAN ANTONIO NU脩EZVELASCO. Apoderado: MIGUEL AMARO CRIADO;FRANCISCO FERRERO GARCIA;FERNANDEZ GONZALEZ JUAN. Apo.Sol.:JESUS DEL POZO MAZO. Apoderado: JOSE LUIS MONTOYA CALVETE. Datos registrales. T 305 , F 123, S 8, H SG 382, I/A 112(25.02.22).
28 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: ANTONIO LOPEZ GARCIA. Datos registrales. T 305 , F 122, S 8, H SG 382, I/A 109 (21.02.22).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ROJAS LOPEZ TOFI脩O ERNESTO. Datos registrales. T 305 , F 122, S 8, H SG 382,I/A 110 (21.02.22).
Nombramientos. Apoderado: JAIME LORENZO ROS. Datos registrales. T 305 , F 123, S 8, H SG 382, I/A 111 (21.02.22).
18 de Junio de 2021Nombramientos. Consejero: JUANA ALVAREZ NADAL. Datos registrales. T 305 , F 121, S 8, H SG 382, I/A 107 ( 8.06.21).
Ceses/Dimisiones. Consejero: VALDECANTOS ALVAREZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 305 , F 122, S 8, H SG 382, I/A108 ( 9.06.21).
25 de Marzo de 2021Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 18潞 de los estatutos sociales.. Otros conceptos: Adici贸n de los art铆culos 15潞bis y 22潞 bis a los estatutos sociales. Datos registrales. T 305 , F 121, S 8, H SG 382, I/A 106 (16.03.21).
17 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: M SEGOVIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 305 , F 120, S 8, H SG 382, I/A 105 (10.03.21).
23 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARO YOSEMITE ARGUELLES ARMADA. Datos registrales. T 305 , F 120, S 8, H SG 382, I/A104 (15.02.21).
05 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO BERNAL ALVAREZ. Apo.Sol.: ZAMANILLO GUTIERREZ ANA;ANTONIO LOPEZGARCIA. Datos registrales. T 305 , F 119, S 8, H SG 382, I/A 102 (21.12.20).
Nombramientos. Apoderado: SIMON ZORNOZA ANDRES. Apo.Sol.: LUIS PANCRACIO BLANCO RODRIGUEZ;ANTONIO LOPEZGARCIA. Datos registrales. T 305 , F 120, S 8, H SG 382, I/A 103 (23.12.20).
04 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JUANA ALVAREZ NADAL;BEATRIZ VALDECANTOS ALVAREZ. Nombramientos. Apoderado:VALDECANTOS ALVAREZ PAULA. SecreNoConsj: ADALBERTO AGUILAR CA脩O. Consejero: DIANA VALDECANTOSALVAREZ;VALDECANTOS ALVAREZ PAULA;VALDECANTOS ALVAREZ JOSE CARLOS;FEDERICO MAURICIO SORIAMARTINEZ;JUAN FRANCISCO LAZCANO ACEDO;ALVARO YOSEMITE ARGUELLES ARMADA. Presidente: VALDECANTOSALVAREZ PAULA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n.Datos registrales. T 305 , F 119, S 8, H SG 382, I/A 101 (26.02.20).
31 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: MANUEL ANTONIO SEGOVIA ADANERO. Aud.Supl.: SALVADOR MU脩OZ-PEREA PI脩AR. Datosregistrales. T 305 , F 118, S 8, H SG 382, I/A 100 (16.01.20).
24 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: DAVID SOLIVA GOBERN;GERARDO GARCIA-LAGO VELARDE. Apo.Sol.: SARA GUTIERREZCAMARA. Apoderado: GERARDO GARCIA LAGO VELARDE. Datos registrales. T 305 , F 118, S 8, H SG 382, I/A 97 (16.12.19).
Nombramientos. Apoderado: ZAMANILLO GUTIERREZ ANA. Datos registrales. T 305 , F 118, S 8, H SG 382, I/A 98 (16.12.19).
Nombramientos. Apoderado: BEATRIZ URIA MORALES. Datos registrales. T 305 , F 118, S 8, H SG 382, I/A 99 (16.12.19).
21 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO FERRERO GARCIA. Datos registrales. T 305 , F 117, S 8, H SG 382, I/A 96 (14.11.19).
24 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: MANUEL JOSE ARTEAGA JIMENEZ. Datos registrales. T 305 , F 117, S 8, H SG 382, I/A 95(17.07.19).
20 de Febrero de 2019Nombramientos. Auditor: SEGOVIA ADANERO MANUEL ANTONIO. Aud.Supl.: SARA GARRIDO GARCIA. Datos registrales. T305 , F 117, S 8, H SG 382, I/A 94 (13.02.19).
24 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: JESUS DEL POZO MAZO;FRANCISCO JOSE DIAZ MORALES. Datos registrales. T 305 , F 116, S 8, HSG 382, I/A 92 (17.12.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: FRANCISCO JOSE HALLADO FERNANDEZ. Apoderado: GERARDO GARCIA LAGO VELARDE. Datosregistrales. T 305 , F 116, S 8, H SG 382, I/A 93 (17.12.18).
28 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: ADALBERTO AGUILAR CA脩O. Datos registrales. T 274 , F 209, S 8, H SG 382, I/A 90 (21.06.18).
Nombramientos. Apoderado: MARIA GARCIA CORDONES. Datos registrales. T 305 , F 116, S 8, H SG 382, I/A 91 (21.06.18).
12 de Abril de 2018Nombramientos. Auditor: SEGOVIA ADANERO MANUEL ANTONIO. Aud.Supl.: SARA GARRIDO GARCIA. Datos registrales. T274 , F 209, S 8, H SG 382, I/A 89 ( 6.04.18).
03 de Agosto de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: CABRERA NARVAEZ ADRIAN;CASTRESANA LOPEZ MIREIA ROSA. Apoderado: BADAS MIGUELANGEL;ELVIRA SERRANO MIGUEL;JOSE ESTEBAN CLIMENT. Datos registrales. T 274 , F 209, S 8, H SG 382, I/A 88 (26.07.17).
08 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SARA GUTIERREZ CAMARA. Datos registrales. T 274 , F 208, S 8, H SG 382, I/A 87 (29.05.17).
15 de Marzo de 2017Ampliacion del objeto social. ab) Dise帽o, investigaci贸n, desarrollo, construcci贸n, instalaci贸n, explotaci贸n, mantenimiento,conservaci贸n, supervisi贸n y certificaci贸n de todo tipo de centros o instalaciones de almacenamiento, gasoductos, redes de distribuci贸n,instalaciones receptoras Individuales o colectivas; as铆 como, de equip. Datos registrales. T 274 , F 208, S 8, H SG 382, I/A 86 (3.03.17).
10 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: SAINZ AJA SAIZ MAZA DAVID. Datos registrales. T 274 , F 207, S 8, H SG 382, I/A 85 ( 2.11.16).
15 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VALDECANTOS MONTES JESUS;VALDECANTOS ALVAREZ JOSE CARLOS. Nombramientos.Adm. Solid.: JUANA ALVAREZ NADAL;BEATRIZ VALDECANTOS ALVAREZ. Datos registrales. T 274 , F 207, S 8, H SG 382, I/A 84(11.07.16).
15 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO DIAZ MORALES. Datos registrales. T 274 , F 206, S 8, H SG 382, I/A 82 ( 8.02.16).
22 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: GERARDO GARCIA-LAGO VELARDE. Datos registrales. T 274 , F 206, S 8, H SG 382, I/A 80(15.07.15).
Nombramientos. Apoderado: JOSE LUIS MONTOYA CALVETE. Datos registrales. T 274 , F 206, S 8, H SG 382, I/A 81 (15.07.15).
18 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: BEGO脩A ANCHELERGUES MARTINEZ. Nombramientos. Apoderado: DAVID SOLIVAGOBERN;JOSE ESTEBAN CLIMENT. Datos registrales. T 274 , F 205, S 8, H SG 382, I/A 79 (10.03.15).
11 de Febrero de 2015Nombramientos. Auditor: SEGOVIA ADANERO, MANUEL ANTONIO. Aud.Supl.: SARA GARRIDO GARCIA. Datos registrales. T274 , F 205, S 8, H SG 382, I/A 78 (29.01.15).
09 de Febrero de 2015Otros conceptos: Aumento del capital asignado a la Sucursal en Per煤 en la suma de S/. 1.900,000.00, es decir, de la cantidad deS/.100.000.00 al monto total de S/. 2.000,000.00. Datos registrales. T 274 , F 205, S 8, H SG 382, I/A 77 (27.01.15).
26 de Enero de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BARRENENGOA ARRIBAS, MARIA ITZIAR;PEREZ VIZAN, FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado:ROUCHER IGLESIAS, MIGUEL. Apo.Sol.: ANDRES BARCENA GONZALEZ;ANTONIO LOPEZ GARCIA. Apoderado: MIGUELAMARO CRIADO. Datos registrales. T 274 , F 204, S 8, H SG 382, I/A 76 (13.01.15).
30 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: ROBERTO YANEZ CA脩AMARES. Datos registrales. T 274 , F 204, S 8, H SG 382, I/A 75 (19.12.14).
23 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: HECTOR RODRIGUEZ PORTEIRO. Datos registrales. T 274 , F 204, S 8, H SG 382, I/A 74(16.09.14).
15 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: ANTONIO LOPEZ GARCIA;FEDERICO MAURICIO SORIA MARTINEZ. Datos registrales. T 274 , F203, S 8, H SG 382, I/A 72 ( 7.04.14).
Ampliacion del objeto social. r) Actividades de tratamiento y disposici贸n final de residuos s贸lidos producto de la limpieza deespacios p煤blicos como v铆as p煤blicas, estaciones, depuradoras, playas y mobiliario urbano. s) Servicios de barrido y recolecci贸n deresiduos s贸lidos producto de la limpieza de espacios p煤blicos como v铆as. Datos registrales. T 274 , F 203, S 8, H SG 382, I/A 73 (7.04.14).
21 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: GARCIA LOPEZ, FRANCISCO. Datos registrales. T 274 , F 202, S 8, H SG 382, I/A 70 (14.02.14).
Nombramientos. Apoderado: BEGO脩A ANCHELERGUES MARTINEZ. Datos registrales. T 274 , F 203, S 8, H SG 382, I/A 71(14.02.14).
22 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: VALDECANTOS ALVAREZ, PAULA. Apoderado: GARCIA LOPEZ, FRANCISCO. Datos registrales. T274 , F 202, S 8, H SG 382, I/A 69 ( 8.01.14).
25 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: VALDECANTOS ALVAREZ, PAULA;GARCIA LOPEZ, FRANCISCO. Datos registrales. T 274 , F 202, S8, H SG 382, I/A 68 (18.11.13).
19 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: DANIEL DOMINGUEZ FROJAN. Datos registrales. T 274 , F 201, S 8, H SG 382, I/A 67 (12.11.13).
10 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: PULIDO RUIZ, JUAN CARLOS. Datos registrales. T 274 , F 201, S 8, H SG 382, I/A 65 ( 3.07.13).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ROJAS LOPEZ TOFI脩O, ERNESTO. Datos registrales. T 274 , F 201, S 8, H SG 382,I/A 66 ( 3.07.13).
21 de Mayo de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: MOLET ABELLAN, ANTONIO;PIZARRO MIAJA, JAVIER. Datos registrales. T 274 , F 200, S 8, H SG 382,I/A 61 (13.05.13).
Nombramientos. Apoderado: ANTONIO LOPEZ GARCIA. Datos registrales. T 274 , F 200, S 8, H SG 382, I/A 62 (13.05.13).
Nombramientos. Apoderado: ELVIRA SERRANO, MIGUEL. Datos registrales. T 274 , F 200, S 8, H SG 382, I/A 63 (13.05.13).
Nombramientos. Apoderado: VAQUERO ANDRES, LAURA. Datos registrales. T 274 , F 201, S 8, H SG 382, I/A 64 (13.05.13).
05 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apoderado: YUSTE DURBAN, MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 274 , F 200, S 8, H SG 382, I/A 60(24.08.12).
27 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: ZAMANILLO GUTIERREZ, ANA. Datos registrales. T 274 , F 200, S 8, H SG 382, I/A 59 (15.06.12).
18 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: SAINZ AJA SAIZ MAZA, DAVID. Datos registrales. T 202 , F 79, S 8, H SG 382, I/A 58 ( 7.05.12).
20 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: VILARI脩O REY, IVAN. Datos registrales. T 202 , F 79, S 8, H SG 382, I/A 57 (11.04.12).
03 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: GARCIA LOPEZ, FRANCISCO. Datos registrales. T 202 , F 79, S 8, H SG 382, I/A 56 (24.01.12).
30 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. unico: VALDECANTOS MONTES JESUS. Nombramientos. Adm. Solid.: VALDECANTOS ALVAREZ,JOSE CARLOS;VALDECANTOS MONTES, JESUS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Ergano de Administracion:Administrador nico a Administradores solidarios. Otros conceptos: Modificacion y adaptacion de los Estatutos Sociales alRealDecreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Sociedades Capital, y en concretomodificacion de los articulos 1 , 4 ,7 , 11 ,12 ,16, 17E, 18E, 19 , 20E, 21 , 22E, 23 y 24 . Datos registrales. T 202 , F 76, S 8, H SG382, I/A 54 (17.01.12).
Nombramientos. Auditor: SEGOVIA ADANERO, MANUEL ANTONIO. Aud.Supl.: MORENO PEREZ, JUSTO. Datos registrales. T202 , F 79, S 8, H SG 382, I/A 55 (18.01.12).
20 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN. Datos registrales. T 202 , F 76, S 8, H SG 382, I/A 53 (11.01.12).
16 de Agosto de 2011Ampliacion del objeto social. g) Servicios de conservaci贸n de carreteras, canales, puertos, aeropuertos,presas, estaciones debombeo y, en general, todo tipo de obras p煤blicas y bienes inmuebles. h) Trabajas de jardiner铆a, plantaci贸n, reforestaci贸n,mantenimiento y conservaci贸n de parques, jardines, espacios naturales, taludes,. Datos registrales. T 202 , F 75, S 8, H SG 382, I/A52 ( 4.08.11).
08 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: ROUCHER IGLESIAS MIGUEL. Datos registrales. T 202 , F 75, S 8, H SG 382, I/A 50 (27.10.10).
Revocaciones. Apo.Sol.: GERWIG LOPEZ DIEGO. Datos registrales. T 202 , F 75, S 8, H SG 382, I/A 51 (27.10.10).
15 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: BADAS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 202 , F 75, S 8, H SG 382, I/A 49 ( 4.10.10).
17 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: VALDECANTOS ALVAREZ JOSE-CARLOS. Datos registrales. T 202 , F 74, S 8, H SG 382, I/A 45 (8.06.10).
Nombramientos. Apoderado: VALDECANTOS ALVAREZ PAULA;ANTONIO LOPEZ GARCIA. Datos registrales. T 202 , F 74, S 8,H SG 382, I/A 46 ( 8.06.10).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA LOPEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 202 , F 74, S 8, H SG 382, I/A 47 ( 8.06.10).
Revocaciones. Apoderado: VALDECANTOS ALVAREZ PAULA. Datos registrales. T 202 , F 74, S 8, H SG 382, I/A 48 ( 8.06.10).
28 de Enero de 2010Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ VILA RAFAEL. Datos registrales. T 202 , F 73, S 8, H SG 382, I/A 43 (19.01.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: CASTRESANA LOPEZ MIREIA ROSA;BARRENENGOA ARRIBAS MARIA ITZIAR. Datos registrales. T202 , F 74, S 8, H SG 382, I/A 44 (19.01.10).
23 de Octubre de 2009Nombramientos. Apoderado: YUSTE DURBAN MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 202 , F 73, S 8, H SG 382, I/A 42(13.10.09).