Actos BORME de Alvendi Sl
06 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE;PERIS GONZALEZ ANDREU;RODRIGUEZ LAHOZCRISTIAN;PEREZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER;MARTINEZ COLLADO MARIA TERESA. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 141,S 8, H V 100146, I/A 22 (27.02.23).
24 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ COLLADO MARIA TERESA. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 141, S 8, H V 100146,I/A 21 (17.05.21).
22 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE. Apo.Manc.: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE;PASTOR QUINTANAFERNANDO;GUAITA BACHILLER PATRICIA. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 141, S 8, H V 100146, I/A 20 (15.03.18).
24 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 139, S 8, H V 100146, I/A 18(17.01.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE;PASTOR QUINTANA FERNANDO;PERIS GONZALEZ ANDREU.Datos registrales. T 7952, L 5247, F 140, S 8, H V 100146, I/A 19 (17.01.18).
04 de Enero de 2018Otros conceptos: DON JOSE-MANUEL GITRAMA ALONSO, con DNI 19.452.736-A, ha sido designado persona física representantede la mercantil "Hostven SL", con CIF B-97.811.830, Administradora única de la entidad "Alvendi SL", Sociedad Unipersonal, con CIFB-97.518.831. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 136, S 8, H V 100146, I/A 7 M (27.12.17).
09 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE;PASTOR QUINTANA FERNANDO;LLORCA PONS ESTHER.Apoderado: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 139, S 8, H V 100146, I/A 17 ( 2.05.17).
05 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE. Apo.Manc.: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE;PASTOR QUINTANAFERNANDO;GUAITA BACHILLER PATRICIA. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 139, S 8, H V 100146, I/A 16 (29.03.17).
17 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE. Apo.Manc.: SANCHEZ BALLESTA ENRIQUE;PASTOR QUINTANAFERNANDO;LLORCA PONS ESTHER. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 138, S 8, H V 100146, I/A 15 ( 9.05.16).
05 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: DASI CHANZA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 138, S 8, H V 100146, I/A 14(27.04.16).
24 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ JUAN. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MARTINEZ JUAN;LLORCA PONSESTHER;ALCAIDE ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 138, S 8, H V 100146, I/A 13 (17.02.16).
22 de Diciembre de 2015Cambio de domicilio social. RONDA NACISO MONTURIOL 6 - PUERTA 203-B, CENTRO E (PATERNA). Datos registrales. T7952, L 5247, F 138, S 8, H V 100146, I/A 12 (15.12.15).
16 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ JUAN. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MARTINEZ JUAN;LLORCA PONSESTHER;ALCAIDE ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 137, S 8, H V 100146, I/A 11 ( 8.05.14).
12 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ JUAN. Apo.Manc.: TEROL CALATAYUD ENRIQUE;MARTINEZ MARTINEZJUAN;ALCAIDE ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 137, S 8, H V 100146, I/A 10 ( 5.11.13).
03 de Febrero de 2011Cambio de domicilio social. PLAZA ALQUERIA DE CULLA 4 - DESPACHO 502/503 (ALFAFAR). Datos registrales. T 7952, L5247, F 137, S 8, H V 100146, I/A 9 (25.01.11).
01 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ JUAN. Apo.Manc.: MARTINEZ MARTINEZ JUAN;TEROL CALATAYUDENRIQUE;ALCAIDE ROMERO ALFONSO. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 137, S 8, H V 100146, I/A 8 (22.06.09).
04 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ALCAIDE ROMERO ALFONSO;TEROL CALATAYUD ENRIQUE. Nombramientos. Adm.Unico: HOSTVEN SOCIEDAD LIMITADA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradoresmancomunados a Administrador único. Datos registrales. T 7952, L 5247, F 136, S 8, H V 100146, I/A 7 (26.05.09).