Actos BORME de Alvento Soluciones Sa
16 de Diciembre de 2019Cierre provisional hoja registral por baja en el 铆ndice de Entidades Jur铆dicas. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 58, S 8, H V78633, I/A34/M1 ( 9.12.19).
24 de Enero de 2018Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 661/2016. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 8/01/2018. Auto de conclusi贸n delconcurso. Inexistencia de bienes. Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL. Juez: FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE.Resoluciones: Se ordena la conclusi贸n del concurso y el archivo de las actuaciones por inexistencia de bienes; se aprueba la cuentarendida por la administraci贸n concursal en su informe de 22 de noviembre de 2017; y se declara la extinci贸n de la sociedad,procediendose al cierre de su hoja de inscripci贸n. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 661/2016. FIRME: Si, Fecha deresoluci贸n 8/01/2018. Cese de las limitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL. Juez:FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 661/2016. Fecha de resoluci贸n19/07/2016. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL. Juez: GARCIA-MIGUEL AGUIRREJAVIER. Administrador Concursal. Fecha 8/01/2018, NIF/CIF 52736992Q. AGUILAR SORIANO MARIANO. Extinci贸n. Datosregistrales. T 9114, L 6398, F 58, S 8, H V 78633, I/A 34 (17.01.18).
18 de Agosto de 2016Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 661/2016. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 19/07/2016. Solicitud de declaraci贸n.Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL. Juez: GARCIA-MIGUEL AGUIRRE JAVIER. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal661/2016. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 19/07/2016. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 DE LOMERCANTIL. Juez: GARCIA-MIGUEL AGUIRRE JAVIER. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 661/2016. Fecha deresoluci贸n 19/07/2016. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL. Juez: GARCIA-MIGUEL AGUIRREJAVIER. Administrador Concursal. Fecha 19/07/2016, NIF/CIF 52736992Q. AGUILAR SORIANO MARIANO. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 661/2016. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 19/07/2016. Resoluciones acordando la intervenci贸n osuspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL. Juez: GARCIA-MIGUEL AGUIRRE JAVIER. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 23, S 8, H V 78633, I/A A (10.08.16).
09 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 23, S 8, H V 78633, I/A 30 (31.12.14).
Reelecciones. Adm. Unico: ZED WORLDWIDE SA. Otros conceptos: Don Javier Perez Dolset, se mantiene como persona fisicarepresentante de la mercantil "Zed Worldwide, S.A.", reelegida administrado unica de la sociedad de esta hoja. Datos registrales. T9114, L 6398, F 23, S 8, H V 78633, I/A 31 (31.12.14).
11 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO ALONSO FRANCISCO. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 22, S 8, H V 78633, I/A 27(30.09.11).
Revocaciones. Apoderado: ORTELLS ROSELL SALVADOR MANUEL. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 23, S 8, H V 78633, I/A28 (30.09.11).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ GAYOSO VARELA RAFAEL. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 23, S 8, H V 78633, I/A 29(30.09.11).
03 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: BAENA GARCIA ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 21, S 8, H V 78633, I/A 26(19.04.11).
15 de Abril de 2011Ampliacion del objeto social. La realizaci贸n de las siguientes actividades a trav茅s de internet o de cualquier otra plataforma detransmisi贸n de datos que pudiera existir en el mercado: a) Prestaci贸n de servicios de acceso, distribuci贸n y exhibici贸n de informaci贸n ocontenidos, propios o ajenos, y de cualquiera otros servicios o. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 21, S 8, H V 78633, I/A 25 (6.04.11).
13 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: GOMEZ GAYOSO VARELA RAFAEL;MORA VEGA JUAN FRANCISCO;DE MIGUEL GUIJARRO ANAMARIA Datos registrales. T 9114, L 6398, F 19, S 8, H V 78633, I/A 24 ( 4.04.11).
25 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: GAMAZO DE ROUX GABRIEL. Fe de erratas: Por error no se envi贸 el cese del Vicesecretario.Datos registrales. T 6950, L 4253, F 32, S 8, H V 78633, I/A 18 (18.12.09).
11 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 19, S 8, H V 78633, I/A 23 ( 2.02.11).
05 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: MARTIN POLLASTRI LUCIANO. Nombramientos. Apoderado: SAN ROMAN SANCHEZ PABLOMANUEL. Modificaci贸n de poderes. Apoderado: BAENA GARCIA ANTONIO JESUS;CONFORTI DIEGO;AGUADO DELICADOOSCAR LUIS;FLORES AYALA NORA NELLY;CEBRIAN GARCIA BALLESTEROS GONZALO MARIA;PEREZ BORRAJOFERNANDO;LILLO BLANC FRANCISCO JAVIER;SANCHIS ANTOLIN JOSE MANUEL;IRIARTE RUIZ MARIA GRACIELA;ARTEAGAGARCIA DANIEL;GAMAZO DE ROUX GABRIEL;LOPEZ DE ARAGON LOPEZ VERONICA;ORTELLS ROSELL SALVADORMANUEL;ARTEAGA GARCIA DANIEL;GAMAZO DE ROUX GABRIEL;ARTEAGA GARCIA DANIEL;GAMAZO DE ROUX GABRIEL.Datos registrales. T 9114, L 6398, F 17, S 8, H V 78633, I/A 22 (26.10.10).
18 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: ORTELLS ROSELL SALVADOR MANUEL. Modificaci贸n de poderes. Apoderado: BAENA GARCIAANTONIO JESUS;CONFORTI DIEGO;AGUADO DELICADO OSCAR LUIS;FLORES AYALA NORA NELLY;CEBRIAN GARCIABALLESTEROS GONZALO MARIA;IRIARTE RUIZ MARIA GRACIELA;MARTIN POLLASTRI LUCIANO;ARTEAGA GARCIADANIEL;GAMAZO DE ROUX GABRIEL;LOPEZ DE ARAGON LOPEZ VERONICA;PEREZ BORRAJO FERNANDO;LILLO BLANCFRANCISCO JAVIER;SANCHIS ANTOLIN JOSE MANUEL. Datos registrales. T 9114, L 6398, F 16, S 8, H V 78633, I/A 21 (9.03.10).
30 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PEREZ DOLSET JAVIER. Consejero: PEREZ DOLSET JAVIER;GOMEZ CAMBRONERO SAINZDE LA MAZA ALVARO. Presidente: PEREZ DOLSET JAVIER. Consejero: ARTEAGA GARCIA DANIEL. Secretario: ARTEAGAGARCIA DANIEL. Nombramientos. Adm. Unico: ZED WORLDWIDE SA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Ar. 13 modificado.. Otros conceptos: Articulo 16 y 17 de losestatutos quedan sin contenido debido a la modificacion del sistema de administracion. El enunciado del art. 18 sera: "Forma dedeliberar de la Junta.". Datos registrales. T 6950, L 4253, F 32, S 8, H V 78633, I/A 18 (18.12.09).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ BORRAJO FERNANDO;LILLO BLANC FRANCISCO JAVIER;SANCHIS ANTOLIN JOSEMANUEL;ALVARO CEBALLOS JAIME;ARTEAGA GARCIA DANIEL;GOMEZ CAMBRONERO SAINZ DE LA MAZA ALVARO. Datosregistrales. T 6950, L 4253, F 32, S 8, H V 78633, I/A 19 (18.12.09).
Nombramientos. Apoderado: BAENA GARCIA ANTONIO JESUS;CONFORTI DIEGO;AGUADO DELICADO OSCAR LUIS;PEREZBORRAJO FERNANDO;FLORES AYALA NORA NELLY;CEBRIAN GARCIA BALLESTEROS GONZALO MARIA;LILLO BLANCFRANCISCO JAVIER;SANCHIS ANTOLIN JOSE MANUEL;IRIARTE RUIZ MARIA GRACIELA;MARTIN POLLASTRILUCIANO;ARTEAGA GARCIA DANIEL;GAMAZO DE ROUX GABRIEL;LOPEZ DE ARAGON LOPEZ VERONICA. Datos registrales.T 6950, L 4253, F 32, S 8, H V 78633, I/A 20 (18.12.09).
23 de Octubre de 2009Cambio de domicilio social. C/ ROGER DE LAURIA 19 5 - LOCAL B, EDIFICIO PARK (VALENCIA). Datos registrales. T 6950, L4253, F 31, S 8, H V 78633, I/A 17 (14.10.09).
13 de Agosto de 2009Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ZED WORLDWIDE HOLDINGS SL. Datos registrales. T 6950, L4253, F 31, S 8, H V 78633, I/A 16 ( 4.08.09).