Buscador CIF Logo

Actos BORME Ama Vida Seguros Y Reaseguros Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ama Vida Seguros Y Reaseguros Sa

Actos BORME Ama Vida Seguros Y Reaseguros Sa - A87623708

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ama Vida Seguros Y Reaseguros Sa con CIF A87623708

馃敊 Perfil de Ama Vida Seguros Y Reaseguros Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ama Vida Seguros Y Reaseguros Sa

14 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUEDA SEGURA JOS EMARIA;ALMUDI ALEGRE JOSE LUIS. Vicepresid.: ALMUDI ALEGRE JOSELUIS. Nombramientos. Consejero: CAMPOS AREVALO RAFAEL;NIEBLAS SILVA JUAN MANUEL. Vicepresid.: GINER MARTINEZJAIME FRANCISCO. M.Comit.Aud: CAMPOS AREVALO RAFAEL;NIEBLAS SILVA JUAN MANUEL;ASTORGA SANCHEZ JUANANTONIO. Pte.Comit.Au: ASTORGA SANCHEZ JUAN ANTONIO. SecComAudit: CAMPOS AREVALO RAFAEL. Datos registrales. T37743 , F 223, S 8, H M 630891, I/A 18 ( 7.08.23).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 37743 , F 224, S 8, H M 630891, I/A 19 ( 7.08.23).

Ceses/Dimisiones. Presidente: MURILLO CARRASCO DIEGO. Vicepresid.: GINER MARTINEZ JAIME FRANCISCO.Nombramientos. Presidente: GINER MARTINEZ JAIME FRANCISCO. Vicepresid.: CAMPOS AREVALO RAFAEL. Datosregistrales. T 37743 , F 225, S 8, H M 630891, I/A 20 ( 7.08.23).

Revocaciones. Apoderado: MURILLO CARRASCO DIEGO. Nombramientos. Apoderado: GINER MARTINEZ JAIME FRANCISCO.Datos registrales. T 37743 , F 225, S 8, H M 630891, I/A 21 ( 7.08.23).

27 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: HIDALGO FERNANDEZ PEDRO. Con.Ind.: MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE. Consejero: VIDANMARTINEZ LUCIANO. Secretario: MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE. Vicesecret.: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO.M.Comit.Aud: MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE. Consejero: HIDALGO FERNANDEZ PEDRO. Nombramientos. Consejero:FUENTES RODRIGUEZ MANUEL;ALMUDI ALEGRE JOSE LUIS;GINER MARTINEZ JAIME FRANCISCO.Vicepresid.: ALMUDIALEGRE JOSE LUIS. Vicesecret.: FUENTES RODRIGUEZ MANUEL. Secretario: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Datosregistrales. T 37743 , F 218, S 8, H M 630891, I/A 15 (20.10.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BUELA FONTENLA JOSEEMILIO. Datos registrales. T 37743 , F 219, S 8, H M 630891, I/A 16 (20.10.22).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 37743 , F 223, S 8, H M 630891, I/A 17 (20.10.22).

26 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. M.Comit.Aud: BELTRAN PONS BARTOLOME. Pte.Comit.Au: BELTRAN PONS BARTOLOME. Fe de erratas:Se omiti贸 publicar por error en la inscripci贸n 11 el cese de BELTRAN PONS BARTOLOME como miembro y presidente del comit茅 deauditor铆a. Datos registrales. T 37743 , F 210, S 8, H M 630891, I/A 11 (18.09.20).

23 de Diciembre de 2021
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.700.000,00 Euros. Desembolsado: 5.700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.715.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 14.715.000,00 Euros. Datos registrales. T 37743 , F 218, S 8, H M 630891, I/A 14 (16.12.21).

18 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE. Secretario: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO.Revocaciones. Apo.Man.Soli: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Nombramientos. Secretario: MARTINEZ AMO FRANCISCOJOSE. Vicesecret.: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Apo.Man.Soli: MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T37743 , F 214, S 8, H M 630891, I/A 13 (11.05.21).

02 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Mmbr.Com.Del: HERRERA GIL FRANCISCO JAVIER. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 11 lapublicaci贸n del cese como miembro de la comisi贸n delegada de don Francisco Javier Herrera Gil. Datos registrales. T 37743 , F 210,S 8, H M 630891, I/A 11 (18.09.20).

21 de Octubre de 2020
Reelecciones. Consejero: MURILLO CARRASCO DIEGO;BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Presidente: MURILLO CARRASCODIEGO. Secretario: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Datos registrales. T 37743 , F 214, S 8, H M 630891, I/A 12 (14.10.20).

25 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRERA GIL FRANCISCO JAVIER. Secretario: HERRERA GIL FRANCISCO JAVIER. Consejero:BELTRAN PONS BARTOLOME. Vicesecret.: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Revocaciones. Apoderado: HERRERA GILFRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: VIDAN MARTINEZ LUCIANO;ASTORGA SANCHEZ JUAN ANTONIO.Secretario: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Vicesecret.: MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE. Apo.Man.Soli: BUELA FONTENLAJOSE EMILIO. Datos registrales. T 37743 , F 210, S 8, H M 630891, I/A 11 (18.09.20).

26 de Febrero de 2020
Revocaciones. Consejero: CAMPOS VILLARINO LUIS MARIA. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 9陋 el cese comoConsejero de CAMPOS VILLARINO LUIS MARIA. Datos registrales. T 37743 , F 209, S 8, H M 630891, I/A 9 (24.09.19).

Nombramientos. Consejero: RUEDA SEGURA JOS EMARIA. Datos registrales. T 37743 , F 209, S 8, H M 630891, I/A 10(19.02.20).

01 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Mmbr.Com.Del: CAMPOS VILLARINO LUIS MARIA. Datos registrales. T 37743 , F 209, S 8, H M 630891, I/A 9(24.09.19).

04 de Marzo de 2019
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SE DEROGAN LOS ANTERIORES.. Datosregistrales. T 35082 , F 34, S 8, H M 630891, I/A 8 (25.02.19).

21 de Febrero de 2019
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.507.500,00 Euros. Datos registrales. T 35082 , F 34, S 8, H M 630891, I/A7 (14.02.19).

26 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Vicesecret.: BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Datos registrales. T 35082 , F 34, S 8, H M 630891, I/A 6(18.12.18).

28 de Junio de 2018
Nombramientos. Con.Ind.: MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE. Consejero: BELTRAN PONS BARTOLOME. M.Comit.Aud:MARTINEZ AMO FRANCISCO JOSE;BELTRAN PONS BARTOLOME. Pte.Comit.Au: BELTRAN PONS BARTOLOME.Modificaciones estatutarias. 25. Administraci贸n y Representaci贸n. 26. Comisi贸n de Auditoria. Datos registrales. T 35082 , F 32, S8, H M 630891, I/A 4 (21.06.18).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35082 , F 33, S 8, H M 630891, I/A 5 (21.06.18).

21 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: MURILLO CARRASCO DIEGO;HERRERA GIL FRANCISCO JAVIER. Mmbr.Com.Del: MURILLOCARRASCO DIEGO;HERRERA GIL FRANCISCO JAVIER;CAMPOS VILLARINO LUIS MARIA. Datos registrales. T 35082 , F 28, S8, H M 630891, I/A 3 (13.12.17).

20 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Consejero: HIDALGO FERNANDEZ PEDRO. Vicepresid.: HIDALGO FERNANDEZ PEDRO. Modificacionesestatutarias. 26. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Datos registrales. T 35082 , F 27, S 8, H M 630891, I/A 2(11.12.17).

09 de Septiembre de 2016
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.07.16. Objeto social: EL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD ASEGURADORA SERA LAPRACTICA DE LAS OPERACIONES DE SEGURO Y REASEGUROS Y DEMAS AUTORIZADAS A LAS ENTIDADESASEGURADORAS POR LA LEGISLACION SOBRE ORDENACION Y SUPERVISION DE LOS SEGUROS PRIVADOS.- Domicilio: C/VIA DE LOS POBLADOS, NUMERO 3, PARQUE EMPRESAR (MADRID). Capital suscrito: 9.015.000,00 Euros. Desembolsado:4.507.500,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA MUTUA DESEGUROS A P. Nombramientos. Consejero: MURILLO CARRASCO DIEGO;HERRERA GIL FRANCISCO JAVIER;CAMPOSVILLARINO LUIS MARIA;BUELA FONTENLA JOSE EMILIO. Presidente: MURILLO CARRASCO DIEGO. Secretario: HERRERA GILFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 35082 , F 25, S 8, H M 630891, I/A 1 ( 1.09.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n