Actos BORME de Amarillos Tour Sa
15 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ MARTIN JESUS MARIA;FUENTES PEREZ RAFAEL;GUTIERREZ MARTIN JESUS MARIA.Apo.Sol.: GUTIERREZ MARTIN JESUS MARIA. Apoderado: ANGEL ESCRIVA LAPUERTA;GUTIERREZ MARTIN JESUSMARIA;SANCHEZ FERNANDEZ-PALACIOS PABLO. Apo.Man.Soli: GUTIERREZ MARTIN JESUS MARIA. Apo.Manc.: SANCHEZFERNANDEZ-PALACIOS PABLO;GUTIERREZ MARTIN JESUS. Datos registrales. T 6904 , F 11, S 8, H SE 11750, I/A 42 ( 3.11.23).
23 de Septiembre de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 12.621,21 Euros. Desembolsado: 12.621,21 Euros. Resultante Suscrito: 239.201,98 Euros.Resultante Desembolsado: 239.201,98 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 6904 , F 10, S 8, H SE 11750, I/A 41 (15.09.22).
06 de Septiembre de 2022Nombramientos. Auditor: DAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6904 , F 10, S 8, H SE 11750, I/A 40 (23.08.22).
27 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ MARTIN JESUS. Presidente: GUTIERREZ MARTIN JESUS. Consejero: GUTIERREZMARTIN VICTOR MANUEL. Secretario: GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL. Consejero: GUTIERREZ MARTIN MILAGROSFATIMA. Vicepresid.: GUTIERREZ MARTIN MILAGROS FATIMA. Nombramientos. Adm. Unico: GUTIERREZ MARTIN VICTORMANUEL. Modificaciones estatutarias. 17. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. 18. Duraci贸n cargo. 19. Organizaci贸nde la administraci贸n de la sociedad.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 5532 , F 160, S 8, H SE 11750, I/A 39 (19.08.20).
11 de Agosto de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 0,42 Euros. Resultante Suscrito: 120.202,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:39.065,65 Euros. Desembolsado: 39.065,65 Euros. Resultante Suscrito: 159.267,65 Euros. Resultante Desembolsado: 159.267,65Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 67.313,12 Euros. Desembolsado: 67.313,12 Euros. Resultante Suscrito: 226.580,77 Euros.Resultante Desembolsado: 226.580,77 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 5532 , F 158, S 8, H SE 11750, I/A 38 ( 3.08.20).
23 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: DAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5532 , F 157, S 8, H SE 11750, I/A 36 (15.07.20).
Reelecciones. Auditor: DAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5532 , F 158, S 8, H SE 11750, I/A 37 (15.07.20).
23 de Octubre de 2019Modificaciones estatutarias. NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 5532 , F 155, S 8, H SE 11750, I/A35 (14.10.19).
04 de Julio de 2018Modificaciones estatutarias. 4. Domicilio social y web corporativa.-. 12. Relativo a la convocatoria de la junta.. Datos registrales. T5532 , F 155, S 8, H SE 11750, I/A 34 (27.06.18).
21 de Junio de 2018Fe de erratas: La fecha correcta del nombramiento de don Jes煤s Guti茅rrez Mart铆n como Presidente es el 25/07/2016. Inscripci贸n 30陋.-La fecha correcta del nombramiento de don Victor Guti茅rrez Mart铆n como Secretario es el 25/07/2016. Inscripci贸n 30陋.- La fechacorrecta del nombramiento de do帽a Milagros F谩tima Guti茅rrez Mart铆n como vicepresidenta es el 25/07/2016. Inscripci贸n 30陋.- Datosregistrales. T 5532 , F 152, S 8, H SE 11750, I/A 30 (15.09.16).
13 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ FERNANDEZ-PALACIOS PABLO;GUTIERREZ MARTIN JESUS;GUTIERREZ MARTINVICTOR MANUEL. Datos registrales. T 5532 , F 153, S 8, H SE 11750, I/A 33 ( 5.06.18).
22 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: DAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 5532 , F 153, S 8, H SE 11750, I/A 32 (14.11.17).
12 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: DAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 5532 , F 153, S 8, H SE 11750, I/A 31 ( 4.01.17).
02 de Diciembre de 2016P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.amarillostour.es. Datos registrales. T 5532 , F 150, S 8, HSE 11750, I/A 24 ( 6.06.12).
23 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ MARTIN MILAGROS FATIMA;GUTIERREZ MARTIN JESUS MARIA;GUTIERREZMARTIN VICTOR MANUEL. Presidente: GUTIERREZ MARTIN JESUS MARIA. Secretario: GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL.Nombramientos. Consejero: GUTIERREZ MARTIN JESUS. Presidente: GUTIERREZ MARTIN JESUS. Consejero: GUTIERREZMARTIN VICTOR MANUEL. Secretario: GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL. Consejero: GUTIERREZ MARTIN MILAGROSFATIMA. Vicepresid.: GUTIERREZ MARTIN MILAGROS FATIMA. Datos registrales. T 5532 , F 152, S 8, H SE 11750, I/A 30(15.09.16).
29 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: DAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 5532 , F 151, S 8, H SE 11750, I/A 28 (15.02.16).
Reelecciones. Auditor: DAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 5532 , F 152, S 8, H SE 11750, I/A 29 (15.02.16).
24 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: DAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 5532 , F 151, S 8, H SE 11750, I/A 27 (17.12.13).
23 de Octubre de 2013Reelecciones. Consejero: GUTIERREZ MARTIN JESUS MARIA;GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL. Presidente: GUTIERREZMARTIN JESUS MARIA. Secretario: GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 5532 , F 150, S 8, H SE 11750,I/A 26 (14.10.13).
08 de Marzo de 2013Reelecciones. Auditor: DAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 5532 , F 150, S 8, H SE 11750, I/A 25 (25.02.13).
20 de Junio de 2012Modificaciones estatutarias. 12. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 5532 , F 150, S 8, H SE 11750, I/A 24 (6.06.12).
23 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: DAL AUDITORES SL. Datos registrales. T 1673 , F 14, S 8, H SE 11750, I/A 23 (12.03.12).
20 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUTIERREZ MARTIN JESUS MARIA;GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL. Datos registrales.T 1673 , F 13, S 8, H SE 11750, I/A 22 ( 8.09.11).
05 de Agosto de 2011Nombramientos. Auditor: TENORIO NAVARRO CARLOS. Datos registrales. T 1673 , F 13, S 8, H SE 11750, I/A 21 (25.07.11).
04 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: GUTIERREZ MARTIN LUIS CARLOS. Consejero: GUTIERREZ MARTIN LUIS CARLOS. Vicepresid.:GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL. Nombramientos. Consejero: GUTIERREZ MARTIN MILAGROS FATIMA. Secretario:GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 1673 , F 12, S 8, H SE 11750, I/A 20 (12.04.11).
29 de Octubre de 2009Nombramientos. Vicepresid.: GUTIERREZ MARTIN VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 1673 , F 12, S 8, H SE 11750, I/A 19(19.10.09).
03 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN PECHARROMAN MARIA ANGELES. Presidente: MARTIN PECHARROMAN MARIAANGELES. Con.Delegado: MARTIN PECHARROMAN MARIA ANGELES. Nombramientos. Presidente: GUTIERREZ MARTINJESUS. Datos registrales. T 1673 , F 11, S 8, H SE 11750, I/A 18 (21.08.09).