Actos BORME de Ambar Telecomunicaciones Sl
26 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 197, S 8, H S 5794, I/A 91(16.08.22).
27 de Enero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GARCIA ROBERTO;GOMEZ SAMANIEGO ION. Datos registrales. T 1061 , F 196, S 8, H S5794, I/A 90 (13.01.22).
20 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: BARCENA VAZQUEZ MARIA-JOSE;BARCENA VAZQUEZ MARIA-JOSE. Datos registrales. T 1061 , F196, S 8, H S 5794, I/A 89 (13.01.22).
30 de Julio de 2021Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 196, S 8, H S 5794, I/A 88(15.07.21).
05 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 196, S 8, H S 5794, I/A 87(21.12.20).
04 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apoderado: CAYON TEJERINA JOSE FRANCISCO;NOVO ALBES ANTONIO LUCIANO. Datos registrales. T 1061, F 195, S 8, H S 5794, I/A 85 (25.08.20).
Revocaciones. Apoderado: CASTANEDO TERAN ALBERTO;SANCHEZ CARO FRANCISCO DANIEL. Apo.Sol.: AGUILERAJIMENEZ MANUEL. Datos registrales. T 1061 , F 195, S 8, H S 5794, I/A 86 (25.08.20).
13 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 195, S 8, H S 5794, I/A 84 ( 1.08.19).
07 de Marzo de 2019Modificaciones estatutarias. 27潞. Que establece el sistema de retribuci贸n de los administradores.-. Datos registrales. T 1061 , F195, S 8, H S 5794, I/A 83 (27.02.19).
02 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 195, S 8, H S 5794, I/A 82(24.07.18).
18 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 195, S 8, H S 5794, I/A 81(10.08.17).
11 de Agosto de 2016Nombramientos. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 195, S 8, H S 5794, I/A 80 (4.08.16).
18 de Agosto de 2015Nombramientos. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 194, S 8, H S 5794, I/A 79(10.08.15).
06 de Agosto de 2015Revocaciones. Apoderado: JORGE GUTIERREZ POZA. Datos registrales. T 1061 , F 194, S 8, H S 5794, I/A 78 (29.07.15).
09 de Abril de 2015Cambio de domicilio social. C/ ALBERT EINSTEIN N潞 8. PARQUE CIENTIFICO Y TECNO (SANTANDER). Datos registrales. T1061 , F 194, S 8, H S 5794, I/A 75 (25.03.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: BORREGO ARIAS JOSE MARIA. Datos registrales. T 1061 , F 194, S 8, H S 5794, I/A 76 (25.03.15).
Nombramientos. Apoderado: NOVO ALBES ANTONIO LUCIANO. Datos registrales. T 1061 , F 194, S 8, H S 5794, I/A 77(25.03.15).
25 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: CARLOS JIMENEZ DE LA MATA;CARLOS JIMENEZ DE LA MATA. Datos registrales. T 1061 , F 193,S 8, H S 5794, I/A 73 (18.11.14).
Revocaciones. Apoderado: MERCHAN HUECAS VANESA. Datos registrales. T 1061 , F 194, S 8, H S 5794, I/A 74 (18.11.14).
02 de Septiembre de 2014Nombramientos. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1061 , F 193, S 8, H S 5794, I/A 72(26.08.14).
18 de Marzo de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: CORREDOIRA ROJO JOSE ENRIQUE. Apoderado: CORTES ROMERO SALVADOR. Datos registrales.T 1061 , F 193, S 8, H S 5794, I/A 71 (11.03.14).
16 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA ROBERTO. Datos registrales. T 1061 , F 193, S 8, H S 5794, I/A 70 ( 5.12.13).
08 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 956 , F 178, S 8, H S 5794, I/A 69 (2.08.13).
30 de Julio de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 169.949,39 Euros. Resultante Suscrito: 200.000,00 Euros. Datos registrales. T 956 , F 178, S 8, H S5794, I/A 68 (22.07.13).
21 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: BARCENA VAZQUEZ MARIA-JOSE. Datos registrales. T 956 , F 178, S 8, H S 5794, I/A 67(13.05.13).
14 de Enero de 2013Revocaciones. Apoderado: CAMPILLO MANDALUNIZ ZALOA. Datos registrales. T 956 , F 177, S 8, H S 5794, I/A 65 ( 3.01.13).
Nombramientos. Apoderado: LLORET MARTI ISIDRO. Datos registrales. T 956 , F 178, S 8, H S 5794, I/A 66 ( 3.01.13).
13 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: MERCHAN HUECAS VANESA. Datos registrales. T 956 , F 177, S 8, H S 5794, I/A 64 ( 3.09.12).
04 de Septiembre de 2012Nombramientos. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 956 , F 177, S 8, H S 5794, I/A 60(22.08.12).
Revocaciones. Apoderado: PUENTE REDONDO JAVIER. Datos registrales. T 956 , F 177, S 8, H S 5794, I/A 61 (23.08.12).
Revocaciones. Apoderado: FROJAN FARI脩A RAFAEL. Datos registrales. T 956 , F 177, S 8, H S 5794, I/A 62 (23.08.12).
Revocaciones. Apo.Sol.: OLMOS OLALLA RAUL. Datos registrales. T 956 , F 177, S 8, H S 5794, I/A 63 (23.08.12).
05 de Septiembre de 2011Nombramientos. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 956 , F 177, S 8, H S 5794, I/A 59(25.08.11).
21 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: CORTES ROMERO SALVADOR. Datos registrales. T 956 , F 176, S 8, H S 5794, I/A 58 ( 8.06.11).
20 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ RUIZ MANUEL ALBERTO;DIEZ DEL VALLE GARZON SARA. Datos registrales. T 956 , F175, S 8, H S 5794, I/A 53 (10.05.11).
Revocaciones. Apoderado: JOSE LUIS BASURTO LEON. Datos registrales. T 956 , F 176, S 8, H S 5794, I/A 54 (10.05.11).
Nombramientos. Apoderado: CARLOS JIMENEZ DE LA MATA. Datos registrales. T 956 , F 176, S 8, H S 5794, I/A 55 (10.05.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: HERRANZ MARCOS JUAN LUIS. Datos registrales. T 956 , F 177, S 8, H S 5794, I/A 57 (10.05.11).
Nombramientos. Apoderado: FROJAN FARI脩A RAFAEL. Datos registrales. T 956 , F 176, S 8, H S 5794, I/A 56 (10.05.11).
30 de Septiembre de 2010Revocaciones. Apoderado: CEA NAVARRO SANTIAGO. Datos registrales. T 956 , F 175, S 8, H S 5794, I/A 51 (20.09.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: BORREGO ARIAS JOSE MARIA;OLMOS OLALLA RAUL. Datos registrales. T 956 , F 175, S 8, H S5794, I/A 52 (20.09.10).
12 de Agosto de 2010Nombramientos. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 956 , F 175, S 8, H S 5794, I/A 50 (2.08.10).
15 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: BARCENA VAZQUEZ MARIA-JOSE. Datos registrales. T 956 , F 175, S 8, H S 5794, I/A 49 (5.04.10).
15 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: DE LA FUENTE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 956 , F 174, S 8, H S 5794,I/A 48 ( 4.01.10).
17 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 956 , F 174, S 8, H S 5794, I/A 47 ( 6.08.09).
29 de Abril de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: GALNARES DEL COSO ELENA. Datos registrales. T 956 , F 174, S 8, H S 5794, I/A 46 (20.04.09).
28 de Enero de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: SALCEDO CLAUSSEN XAVIER ADOLFO. Datos registrales. T 956 , F 174, S 8, H S 5794, I/A 45(19.01.09).