Buscador CIF Logo

Actos BORME Ambitec Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ambitec Sa

Actos BORME Ambitec Sa - A50652437

Tenemos registrados 42 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Ambitec Sa con CIF A50652437

馃敊 Perfil de Ambitec Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Ambitec Sa

14 de Agosto de 2019
Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE SEIS MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 DELREGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL. Datos registrales. T 4013 , F 211, S 8, H Z 17036, I/A 60 N ( 6.08.19).

11 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: NICOLAS LANDRE JULIEN. Secretario: NICOLAS LANDRE JULIEN. Nombramientos. Secretario:DE LA ROSA COZAR MARIA DOLORES. Datos registrales. T 4013 , F 210, S 8, H Z 17036, I/A 60 ( 4.06.19).

17 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: NICOLAS LANDRE JULIEN. Apo.Manc.: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;LASHERAS LOPEZMARIA-DOLORES. Datos registrales. T 4013 , F 210, S 8, H Z 17036, I/A 59 (10.04.19).

02 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apoderado: GUERRERO FERNANDEZ VICTORIA. Datos registrales. T 4013 , F 210, S 8, H Z 17036, I/A 58(25.07.18).

31 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;NICOLAS LANDREJULIEN;MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4013 , F 210, S 8, H Z 17036, I/A 57 (23.05.18).

21 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4013 , F 210,S 8, H Z 17036, I/A 56 (14.11.17).

15 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Secretario: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Nombramientos. Consejero:NICOLAS LANDRE JULIEN. Secretario: NICOLAS LANDRE JULIEN. Datos registrales. T 4013 , F 208, S 8, H Z 17036, I/A 54 (7.11.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: NICOLAS LANDRE JULIEN. Apo.Manc.: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;LASHERAS LOPEZMARIA-DOLORES. Datos registrales. T 4013 , F 208, S 8, H Z 17036, I/A 55 ( 7.11.17).

01 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Presidente: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE.Nombramientos. Consejero: DUPLAN LUDOVIC MICHEL ALAIN. Presidente: DUPLAN LUDOVIC MICHEL ALAIN. Datosregistrales. T 4013 , F 207, S 8, H Z 17036, I/A 53 (24.07.17).

25 de Julio de 2017
Reelecciones. Consejero: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Presidente: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Datosregistrales. T 4013 , F 207, S 8, H Z 17036, I/A 52 (18.07.17).

11 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;MARTINEZGARCIA JOSE MANUEL;NICOLAS LANDRE JULIEN. Datos registrales. T 4013 , F 205, S 8, H Z 17036, I/A 51 (31.10.16).

16 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.: LOPEZ GONZALEZPEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ MARIA ASUNCION. Datos registrales. T 4013 , F 205, S 8, H Z17036, I/A 50 ( 9.12.15).

11 de Agosto de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Apo.Manc.: LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ ASUNCION;FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Datos registrales. T 4013 , F 204, S 8, H Z 17036,I/A 49 ( 3.08.15).

27 de Mayo de 2015
Reelecciones. Consejero: LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Secretario: LOPEZ GONZALEZPEDRO. Datos registrales. T 4013 , F 204, S 8, H Z 17036, I/A 48 (19.05.15).

21 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4013 , F 204, S8, H Z 17036, I/A 47 (13.01.15).

06 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.:MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4013 , F 203, S 8, H Z 17036, I/A 46 (25.09.14).

11 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;MARTINEZ

08 de Agosto de 2014
Reelecciones. Consejero: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Con.Delegado: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 4013 , F 202, S 8, H Z 17036, I/A 44 ( 1.08.14).

12 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.:ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Apo.Sol.: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Sol.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Datosregistrales. T 4013 , F 202, S 8, H Z 17036, I/A 43 ( 3.03.14).

03 de Febrero de 2014
Fe de erratas: Rectificada la inscripci贸n 41&, en el sentido de que el DNI CORRECTO de Don Feliciano Manuel Sanchez Mar铆nFlores, es "17.727.570K" y no "17.725.570K". Datos registrales. T 3771 , F 160, S 8, H Z 17036, I/A 42 (24.01.14).

07 de Enero de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANOMANUEL;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ ASUNCION. Datos registrales. T3771 , F 160, S 8, H Z 17036, I/A 41 (23.12.13).

06 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Apo.Sol.: FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Datos registrales. T 3771 , F 157, S 8, H Z17036, I/A 37 (29.07.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Datosregistrales. T 3771 , F 158, S 8, H Z 17036, I/A 38 (29.07.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Apo.Sol.: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Datos registrales. T 3771 , F 159, S 8, H Z17036, I/A 39 (29.07.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Sol.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Datos registrales. T 3771 , F 160, S8, H Z 17036, I/A 40 (29.07.13).

14 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;MARTINEZGARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3771 , F 157, S 8, H Z 17036, I/A 36 ( 4.09.12).

24 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3771 , F 156, S8, H Z 17036, I/A 35 (12.01.12).

15 de Septiembre de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE;MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;FORNIES ANDRES JOSEMARIA. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ MARIA ASUNCION. Apo.Man.Soli: SANCHEZMARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ MARIA ASUNCION.Apo.Man.Soli: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ MARIA ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Apo.Sol.: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE;LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Manc.: LOPEZ DE LA GARMAALEJANDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;QUIXANOBURGOS JUAN-JOSE;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS;LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datosregistrales. T 3771 , F 156, S 8, H Z 17036, I/A 34 ( 1.09.11).

06 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;MARTINEZGARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3771 , F 155, S 8, H Z 17036, I/A 33 (25.08.11).

11 de Agosto de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Apo.Manc.: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE;LASHERAS LOPEZMARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ ASUNCION. Datos registrales. T 3771 , F 153, S 8, H Z 17036, I/A 29 ( 1.08.11).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Manc.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO;LASHERASLOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;ARANDA GIMENEZ ASUNCION. Datos registrales. T 3771 , F 153, S 8, H Z17036, I/A 30 ( 1.08.11).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Apo.Manc.: FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Apoderado:LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Datosregistrales. T 3771 , F 154, S 8, H Z 17036, I/A 31 ( 1.08.11).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.: LOPEZ GONZALEZPEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ ASUNCION;SANCHEZ MARIN FLORES FELICIANO MANUEL.Datos registrales. T 3771 , F 155, S 8, H Z 17036, I/A 32 ( 1.08.11).

04 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: ROVERATO VINCENT. Consejero: ROVERATO VINCENT. Nombramientos. Consejero:PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Presidente: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Datos registrales. T 3771 , F 152, S 8, HZ 17036, I/A 28 (23.03.11).

15 de Noviembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 27.336,00 Euros. Desembolsado: 27.336,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.336,00 Euros.Resultante Desembolsado: 90.336,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AMBITEC MANTENIMIENTO SA.AMBITEC SISTEMAS SL. Datos registrales. T 3771 , F 152, S 8, H Z 17036, I/A 27 ( 2.11.10).

06 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: ROVERATO VINCENT.Presidente: ROVERATO VINCENT. Datos registrales. T 3771 , F 152, S 8, H Z 17036, I/A 26 (25.06.10).

26 de Abril de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MA脩ARICUA CAMPINS FRANCISCO. Datos registrales. T 2945 , F 82, S 8, H Z 17036, I/A 23(15.04.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Manc.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO;LASHERASLOPEZ MARIA-DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS;LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 2945 , F 82, S 8, H Z17036, I/A 24 (15.04.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: QUIXANO BURGOS JUAN JOSE. Apo.Manc.: QUIXANO BURGOS JUAN JOSE;LASHERAS LOPEZMARIA-DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS;LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 2945 , F 83, S 8, H Z 17036,I/A 25 (15.04.10).

02 de Julio de 2009
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL PARQUE TECNOLOGICO DE COGULLADA, (ZARAGOZA). Datos registrales. T2945 , F 82, S 8, H Z 17036, I/A 20 (23.06.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LECHARNY FRANCOIS MICHEL MARIE. Secretario: LECHARNY FRANCOIS MICHEL MARIE.Consejero: SERRALTA JEAN MARIE FRANCOIS. Presidente: SERRALTA JEAN MARIE FRANCOIS. Consejero: ROCHE MAXANDRE JOSEPH. Nombramientos. Consejero: LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Presidente:MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Secretario: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 2945 , F 82, S 8, H Z 17036, I/A21 (23.06.09).

Cambio de objeto social. El objeto social est谩 integrado por la contrataci贸n, ejecuci贸n y gesti贸n de todo tipo de obras, construccionese instalaciones tanto p煤blicas como privadas, relacionadas con las siguientes actividades: a) La fabricaci贸n, venta, compra, importaci贸no exportaci贸n, representaci贸n y comercializaci贸n de. Datos registrales. T 2945 , F 82, S 8, H Z 17036, I/A 22 (23.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n