Actos BORME de Ambitec Sa
14 de Agosto de 2019Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE SEIS MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 DELREGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL. Datos registrales. T 4013 , F 211, S 8, H Z 17036, I/A 60 N ( 6.08.19).
11 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: NICOLAS LANDRE JULIEN. Secretario: NICOLAS LANDRE JULIEN. Nombramientos. Secretario:DE LA ROSA COZAR MARIA DOLORES. Datos registrales. T 4013 , F 210, S 8, H Z 17036, I/A 60 ( 4.06.19).
17 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: NICOLAS LANDRE JULIEN. Apo.Manc.: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;LASHERAS LOPEZMARIA-DOLORES. Datos registrales. T 4013 , F 210, S 8, H Z 17036, I/A 59 (10.04.19).
02 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: GUERRERO FERNANDEZ VICTORIA. Datos registrales. T 4013 , F 210, S 8, H Z 17036, I/A 58(25.07.18).
31 de Mayo de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;NICOLAS LANDREJULIEN;MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4013 , F 210, S 8, H Z 17036, I/A 57 (23.05.18).
21 de Noviembre de 2017Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4013 , F 210,S 8, H Z 17036, I/A 56 (14.11.17).
15 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Secretario: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Nombramientos. Consejero:NICOLAS LANDRE JULIEN. Secretario: NICOLAS LANDRE JULIEN. Datos registrales. T 4013 , F 208, S 8, H Z 17036, I/A 54 (7.11.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NICOLAS LANDRE JULIEN. Apo.Manc.: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;LASHERAS LOPEZMARIA-DOLORES. Datos registrales. T 4013 , F 208, S 8, H Z 17036, I/A 55 ( 7.11.17).
01 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Presidente: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE.Nombramientos. Consejero: DUPLAN LUDOVIC MICHEL ALAIN. Presidente: DUPLAN LUDOVIC MICHEL ALAIN. Datosregistrales. T 4013 , F 207, S 8, H Z 17036, I/A 53 (24.07.17).
25 de Julio de 2017Reelecciones. Consejero: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Presidente: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Datosregistrales. T 4013 , F 207, S 8, H Z 17036, I/A 52 (18.07.17).
11 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;MARTINEZGARCIA JOSE MANUEL;NICOLAS LANDRE JULIEN. Datos registrales. T 4013 , F 205, S 8, H Z 17036, I/A 51 (31.10.16).
16 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.: LOPEZ GONZALEZPEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ MARIA ASUNCION. Datos registrales. T 4013 , F 205, S 8, H Z17036, I/A 50 ( 9.12.15).
11 de Agosto de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Apo.Manc.: LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ ASUNCION;FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Datos registrales. T 4013 , F 204, S 8, H Z 17036,I/A 49 ( 3.08.15).
27 de Mayo de 2015Reelecciones. Consejero: LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Secretario: LOPEZ GONZALEZPEDRO. Datos registrales. T 4013 , F 204, S 8, H Z 17036, I/A 48 (19.05.15).
21 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4013 , F 204, S8, H Z 17036, I/A 47 (13.01.15).
06 de Octubre de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.:MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4013 , F 203, S 8, H Z 17036, I/A 46 (25.09.14).
11 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;MARTINEZ
08 de Agosto de 2014Reelecciones. Consejero: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Con.Delegado: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 4013 , F 202, S 8, H Z 17036, I/A 44 ( 1.08.14).
12 de Marzo de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.:ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Apo.Sol.: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Sol.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Datosregistrales. T 4013 , F 202, S 8, H Z 17036, I/A 43 ( 3.03.14).
03 de Febrero de 2014Fe de erratas: Rectificada la inscripci贸n 41&, en el sentido de que el DNI CORRECTO de Don Feliciano Manuel Sanchez Mar铆nFlores, es "17.727.570K" y no "17.725.570K". Datos registrales. T 3771 , F 160, S 8, H Z 17036, I/A 42 (24.01.14).
07 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANOMANUEL;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ ASUNCION. Datos registrales. T3771 , F 160, S 8, H Z 17036, I/A 41 (23.12.13).
06 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Apo.Sol.: FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Datos registrales. T 3771 , F 157, S 8, H Z17036, I/A 37 (29.07.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ-MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Datosregistrales. T 3771 , F 158, S 8, H Z 17036, I/A 38 (29.07.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Apo.Sol.: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Datos registrales. T 3771 , F 159, S 8, H Z17036, I/A 39 (29.07.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZPEDRO;LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Sol.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Datos registrales. T 3771 , F 160, S8, H Z 17036, I/A 40 (29.07.13).
14 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;MARTINEZGARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3771 , F 157, S 8, H Z 17036, I/A 36 ( 4.09.12).
24 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3771 , F 156, S8, H Z 17036, I/A 35 (12.01.12).
15 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE;MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL;FORNIES ANDRES JOSEMARIA. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ MARIA ASUNCION. Apo.Man.Soli: SANCHEZMARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ MARIA ASUNCION.Apo.Man.Soli: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ MARIA ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Apo.Sol.: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE;LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Manc.: LOPEZ DE LA GARMAALEJANDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;QUIXANOBURGOS JUAN-JOSE;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS;LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datosregistrales. T 3771 , F 156, S 8, H Z 17036, I/A 34 ( 1.09.11).
06 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;MARTINEZGARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3771 , F 155, S 8, H Z 17036, I/A 33 (25.08.11).
11 de Agosto de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE. Apo.Manc.: QUIXANO BURGOS JUAN-JOSE;LASHERAS LOPEZMARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ ASUNCION. Datos registrales. T 3771 , F 153, S 8, H Z 17036, I/A 29 ( 1.08.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Manc.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO;LASHERASLOPEZ MARIA-DOLORES;LOPEZ GONZALEZ PEDRO;ARANDA GIMENEZ ASUNCION. Datos registrales. T 3771 , F 153, S 8, H Z17036, I/A 30 ( 1.08.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Apo.Manc.: FORNIES ANDRES JOSE MARIA. Apoderado:LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Apo.Manc.: ARANDA GIMENEZ ASUNCION;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Datosregistrales. T 3771 , F 154, S 8, H Z 17036, I/A 31 ( 1.08.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MARIN FLORES FELICIANO MANUEL. Apo.Manc.: LOPEZ GONZALEZPEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES;ARANDA GIMENEZ ASUNCION;SANCHEZ MARIN FLORES FELICIANO MANUEL.Datos registrales. T 3771 , F 155, S 8, H Z 17036, I/A 32 ( 1.08.11).
04 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: ROVERATO VINCENT. Consejero: ROVERATO VINCENT. Nombramientos. Consejero:PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Presidente: PERETMERE ARNAUD JEAN ANDRE. Datos registrales. T 3771 , F 152, S 8, HZ 17036, I/A 28 (23.03.11).
15 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 27.336,00 Euros. Desembolsado: 27.336,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.336,00 Euros.Resultante Desembolsado: 90.336,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AMBITEC MANTENIMIENTO SA.AMBITEC SISTEMAS SL. Datos registrales. T 3771 , F 152, S 8, H Z 17036, I/A 27 ( 2.11.10).
06 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: ROVERATO VINCENT.Presidente: ROVERATO VINCENT. Datos registrales. T 3771 , F 152, S 8, H Z 17036, I/A 26 (25.06.10).
26 de Abril de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: MA脩ARICUA CAMPINS FRANCISCO. Datos registrales. T 2945 , F 82, S 8, H Z 17036, I/A 23(15.04.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO. Apo.Manc.: LOPEZ DE LA GARMA ALEJANDRO;LASHERASLOPEZ MARIA-DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS;LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 2945 , F 82, S 8, H Z17036, I/A 24 (15.04.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: QUIXANO BURGOS JUAN JOSE. Apo.Manc.: QUIXANO BURGOS JUAN JOSE;LASHERAS LOPEZMARIA-DOLORES;CORCOLES GARCIA JOSE LUIS;LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 2945 , F 83, S 8, H Z 17036,I/A 25 (15.04.10).
02 de Julio de 2009Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL PARQUE TECNOLOGICO DE COGULLADA, (ZARAGOZA). Datos registrales. T2945 , F 82, S 8, H Z 17036, I/A 20 (23.06.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LECHARNY FRANCOIS MICHEL MARIE. Secretario: LECHARNY FRANCOIS MICHEL MARIE.Consejero: SERRALTA JEAN MARIE FRANCOIS. Presidente: SERRALTA JEAN MARIE FRANCOIS. Consejero: ROCHE MAXANDRE JOSEPH. Nombramientos. Consejero: LOPEZ GONZALEZ PEDRO;LASHERAS LOPEZ MARIA-DOLORES. Presidente:MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL. Secretario: LOPEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 2945 , F 82, S 8, H Z 17036, I/A21 (23.06.09).
Cambio de objeto social. El objeto social est谩 integrado por la contrataci贸n, ejecuci贸n y gesti贸n de todo tipo de obras, construccionese instalaciones tanto p煤blicas como privadas, relacionadas con las siguientes actividades: a) La fabricaci贸n, venta, compra, importaci贸no exportaci贸n, representaci贸n y comercializaci贸n de. Datos registrales. T 2945 , F 82, S 8, H Z 17036, I/A 22 (23.06.09).