Buscador CIF Logo

Actos BORME Ambito Grupo Empresarial Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ambito Grupo Empresarial Sl

Actos BORME Ambito Grupo Empresarial Sl - B84954270

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ambito Grupo Empresarial Sl con CIF B84954270

馃敊 Perfil de Ambito Grupo Empresarial Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ambito Grupo Empresarial Sl

16 de Marzo de 2015
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 705/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 21/11/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ. Datos registrales.T 26652 , F 71, S 8, H M 427741, I/A 19 ( 9.03.15).

26 de Enero de 2015
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 705/2014. Fecha de resoluci贸n 21/11/2014. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ. Administrador Concursal. Fecha21/11/2014, NIF/CIF 07212861S. ALEMANY POZUELO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 26652 , F 71, S 8, H M 427741, I/AB (16.01.15).

12 de Diciembre de 2014
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 705/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 21/11/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ. Datos registrales.T 26652 , F 71, S 8, H M 427741, I/A A ( 3.12.14).

22 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: IZQUIERDO MERLO EMILIO;VAZQUEZ ROMERO TOMAS PABLO;IZQUIERDO JIMENEZEMILIO;IGLESIAS SANCHEZ SARA;HERNANDEZ GENIS NIEVES;IGLESIAS BRANTUAS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T26652 , F 70, S 8, H M 427741, I/A 18 (10.11.10).

04 de Junio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ ROMERO TOMAS PABLO;VAZQUEZ VERA ANDRES. Con.Delegado: VAZQUEZ VERAANDRES. Consejero: VAZQUEZ ROMERO ANDRES;IGLESIAS BRANTUAS JOSE ANTONIO. Con.Delegado: IGLESIAS BRANTUASJOSE ANTONIO. Presidente: VAZQUEZ VERA ANDRES. SecreNoConsj: HERNANDEZ GENIS NIEVES. Nombramientos.Representan: VAZQUEZ VERA ANDRES. Adm. Unico: GADESO 2003 SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 26652 , F 70, S 8, H M 427741, I/A 17(25.05.10).

02 de Junio de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: TABERNA JIMENEZ CARLOS;SENOSIAIN MURILLO FRANCISCO JAVIER;SENOSIAIN MURILLOJOSE JOAQUIN. Consejero: IZQUIERDO JIMENEZ EMILIO;IZQUIERDO MERLO EMILIO;INVERSIONES TOSEN SL;PARCELAESTUDIO SL;SENOSIAIN MURILLO FRANCISCO JAVIER. Presidente: IZQUIERDO JIMENEZ EMILIO. Consejero: INVERSIONESHETASE SL. Nombramientos. Consejero: VAZQUEZ ROMERO ANDRES;IGLESIAS BRANTUAS JOSE ANTONIO. Con.Delegado:IGLESIAS BRANTUAS JOSE ANTONIO. Presidente: VAZQUEZ VERA ANDRES. Datos registrales. T 26652 , F 69, S 8, H M427741, I/A 16 (25.05.10).

27 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALPERI GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 26652 , F 69, S 8, H M 427741, I/A 15 (17.05.10).

25 de Junio de 2009
Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS BRANTUAS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 26652 , F 66, S 8, H M 427741, I/A 14(15.06.09).

21 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ ROMERO ANDRES. Datos registrales. T 23831 , F 224, S 8, H M 427741, I/A 12 (8.05.09).

Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GENIS NIEVES. Datos registrales. T 26652 , F 63, S 8, H M 427741, I/A 13 ( 8.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n