Buscador CIF Logo

Actos BORME Amex Asesores De Seguros Sociedad De Agencia De Seguros Vinculada Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Amex Asesores De Seguros Sociedad De Agencia De Seguros Vinculada Sa

Actos BORME Amex Asesores De Seguros Sociedad De Agencia De Seguros Vinculada Sa - A79770608

Tenemos registrados 57 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Amex Asesores De Seguros Sociedad De Agencia De Seguros Vinculada Sa con CIF A79770608

馃敊 Perfil de Amex Asesores De Seguros Sociedad De Agencia De Seguros Vinculada Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Amex Asesores De Seguros Sociedad De Agencia De Seguros Vinculada Sa

15 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: MORENO BRITAPAJA ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ PEREZ MARIA. Datosregistrales. T 43936 , F 142, S 8, H M 10859, I/A 102 ( 8.09.23).

Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 28潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 43936 , F 143, S 8, H M10859, I/A 103 ( 8.09.23).

13 de Junio de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: LINARES PEREZ PILAR. Datos registrales. T 43936 , F 142, S 8, H M 10859, I/A 101 ( 6.06.23).

23 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: LANDRIEU HELENE BRIGITTE CECILE;MU脩OZ BERZAL ALEJANDRO. Datos registrales. T 43936 ,F 141, S 8, H M 10859, I/A 100 (15.03.23).

21 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: OLMOS LOPEZ MIRNA. Datos registrales. T 43936 , F 141, S 8, H M 10859, I/A 99 (13.03.23).

16 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Secretario: BELZUZ LARRUY ENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ LABRADOR EMILIODANIEL. Datos registrales. T 43936 , F 140, S 8, H M 10859, I/A 98 ( 9.02.23).

15 de Febrero de 2023
Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 20 y 21 de los estatutos, relativos a convocatoria, constituci贸n, deliberaci贸n yacuerdos del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 43936 , F 140, S 8, H M 10859, I/A 97 ( 8.02.23).

22 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Apo.Manc.: DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Apo.Sol.:DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Nombramientos. Apo.Sol.: LANDRIEU HELENE BRIGITTE CECILE;CERDEIRAESTIRADO JOSE MANUEL;GONZALEZ DELGADO NATALIA-ELIANA;BOVEDA MELERO ROSARIO. Datos registrales. T 28332 , F223, S 8, H M 10859, I/A 96 (15.11.22).

Otros conceptos: Ha cambiado el domicilio social del Socio Unico, la sociedad "AMERICAN EXPRESS DE ESPA脩A, S.A.", a laAvenida del Parten贸n, n煤mero 12-14, Campo de las Naciones, de 28042 Madrid. Datos registrales. T 704 , F 35, S 8, H M 10859, I/A13M (15.11.22).

13 de Abril de 2022
Nombramientos. Coauditor: MAZARS AUDITORES SLP;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Auditor: MAZARSAUDITORES SLP. Datos registrales. T 28332 , F 223, S 8, H M 10859, I/A 95 ( 6.04.22).

06 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: HUBERT MATHILDE SOPHIE. Nombramientos. Apo.Sol.: BERTRAND ELSA OPHELIE;BARNESANDREW ROBERT. Otros conceptos: Se actualizan los datos personales del apoderado nombrado en la inscripci贸n 84陋 don JamesJohn Houghton, en cuanto a su domicilio y al n煤mero de su pasaporte, siendo el nuevo n煤mero 5553664. Datos registrales. T 28332 ,F 222, S 8, H M 10859, I/A 94 (30.03.22).

07 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Apoderado: DINESEN VILLACIEROS MARIAELENA;CERDEIRA ESTIRADO JOSE MANUEL;SIERRA OLALLA BEGO脩A. Datos registrales. T 28332 , F 222, S 8, H M 10859, I/A93 (30.09.20).

05 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 222, S 8, H M 10859, I/A92 (28.09.20).

23 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 221, S 8, H M 10859, I/A91 (16.10.19).

27 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DEL PINO ANA. Datos registrales. T 28332 , F 221, S 8, H M 10859, I/A 90 (20.05.19).

29 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Man.Soli: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZPAZ. Apo.Sol.: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Nombramientos. Apoderado: BOVEDA MELERO ROSARIO;SIERRAOLALLA BEGO脩A. Datos registrales. T 28332 , F 220, S 8, H M 10859, I/A 89 (20.11.18).

24 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 219, S 8, H M 10859, I/A88 (17.10.18).

09 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Revocaciones. Apoderado: ANDRADAVANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ;ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ;ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ.Nombramientos. Consejero: SIERRA OLALLA BEGO脩A. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;ORTIOCHOA DE OCARIZ JUAN. Con.Delegado: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Presidente: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Datosregistrales. T 28332 , F 219, S 8, H M 10859, I/A 87 ( 2.08.18).

22 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: BOVEDA MELERO ROSARIO. Datos registrales. T 28332 , F 218, S 8, H M 10859, I/A 86 (15.06.18).

22 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Datos registrales. T 28332 , F 218, S 8, H M 10859, I/A 85(15.02.18).

20 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: ALONSO FERNANDEZ LUIS. Apo.Sol.: ALONSO FERNANDEZ LUIS. Apoderado: MONTEROGUTIERREZ ADOLFO;MONTERO GUTIERREZ ADOLFO;DIXON SOPHIE-ANNE-DOMINIQUE;MONTERO GUTIERREZ ADOLFO.Nombramientos. Apo.Sol.: HOUGHTON JAMES JOHN. Apoderado: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Man.Soli:ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Sol.: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Datos registrales. T 28332 , F216, S 8, H M 10859, I/A 84 (12.12.17).

27 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 28332 , F 216, S 8, H M 10859, I/A 82 (16.11.17).

Cambio de domicilio social. AVDA DEL PARTENON 12-14 - CAMPO DE LAS NACIONES (MADRID). Datos registrales. T 28332 ,F 216, S 8, H M 10859, I/A 83 (20.11.17).

08 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 215, S 8, H M 10859, I/A81 (30.10.17).

22 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ RODRIGUEZ CRISTINA LETICIA;MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Datos registrales. T28332 , F 215, S 8, H M 10859, I/A 80 (14.09.17).

14 de Junio de 2017
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ PATON JACINTO;ALEU RODRIGUEZ JUAN ELIAS;VIDAURRE ACOSTA FRANCISCOJAVIER. Apo.Manc.: RODRIGUEZ SACRISTAN DIEGO. Nombramientos. Apoderado: DIXON SOPHIE-ANNE-DOMINIQUE;HUBERT MATHILDE SOPHIE. Datos registrales. T 28332 , F 214, S 8, H M 10859, I/A 79 ( 6.06.17).

01 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Datos registrales. T 28332 , F 214, S 8, H M 10859, I/A 78(22.02.17).

11 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apoderado: SUAREZ DE LEZO Y CRUZ CONDE RAFAEL. Datos registrales. T 28332 , F 214, S 8, H M 10859, I/A77 (30.09.16).

26 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 214, S 8, H M 10859, I/A76 (16.08.16).

24 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBAS PABLO ALEJANDRO. Presidente: RIBAS PABLO ALEJANDRO. Revocaciones. Apoderado:RIBAS PABLO ALEJANDRO. Nombramientos. Presidente: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Con.Delegado: ORTI OCHOA DEOCARIZ JUAN. Datos registrales. T 28332 , F 213, S 8, H M 10859, I/A 75 (14.06.16).

21 de Junio de 2016
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 2陋 EL PODER OTORGADO A BNEDICTO ALFREDO, SIENDO LOCORRECTO BENEDICTO ALFREDO QUE FUE REVOCADO EN LA INSCRIPCION 4陋. Datos registrales. T 704 , F 29, S 8, H M10859, I/A 2 (25.03.91).

07 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MEYER PELLEGRINI EMILIO MARTIN. Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIAELENA;RODRIGUEZ SACRISTAN DIEGO FERNANDO;TORRES SOLER PATRICIA.Apo.Sol.: TORRES SOLER PATRICIA.Nombramientos. VsecrNoConsj: RAMAJO SANZ CLAUDIA. Datos registrales. T 28332 , F 213, S 8, H M 10859, I/A 74 (26.02.16).

26 de Agosto de 2015
Nombramientos. Apoderado: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN;FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;RIBAS PABLOALEJANDRO;MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Datos registrales. T 28332 , F 212, S 8, H M 10859, I/A 73 (18.08.15).

19 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 212, S 8, H M 10859, I/A71 (10.08.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Presidente: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO.Con.Delegado: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Nombramientos. Consejero: ALONSO FERNANDEZ LUIS;RIBAS PABLOALEJANDRO. Presidente: RIBAS PABLO ALEJANDRO. Con.Delegado: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Datos registrales. T28332 , F 212, S 8, H M 10859, I/A 72 (10.08.15).

11 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: RAMOS VALVERDE ANA MARIA. Datos registrales. T 28332 , F 212, S 8, H M 10859, I/A 70 ( 3.03.15).

13 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apoderado: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Man.Soli: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZPAZ. Nombramientos. Consejero: MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Apoderado: MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Datos

10 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 210, S 8, H M 10859, I/A68 ( 2.10.14).

28 de Enero de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ MANUEL;MARTINEZ LOPEZ MANUEL;MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Apo.Manc.:MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Apo.Sol.: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Apo.Manc.: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales.T 28332 , F 210, S 8, H M 10859, I/A 67 (20.01.14).

05 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 210, S 8, H M 10859, I/A66 (29.07.13).

26 de Julio de 2013
Revocaciones. Apoderado: NOZAL MARTIN JUAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;ORTIOCHOA DE OCARIZ JUAN;ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Sol.: CHELTON PEREZ IRENE. Apo.Manc.:

02 de Abril de 2013
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 208, S 8, H M 10859,I/A 64 (19.03.13).

26 de Marzo de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 208, S 8, H M 10859, I/A63 (19.03.13).

13 de Febrero de 2013
Nombramientos. VsecrNoConsj: MEYER PELLEGRINI EMILIO MARTIN. Datos registrales. T 28332 , F 207, S 8, H M 10859, I/A 61( 5.02.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 28332 , F 207, S 8, H M 10859, I/A 62 ( 5.02.13).

17 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO;MARTINEZ LOPEZ MANUEL;ANDRADA VANDERWILDESANZ BRIZ PAZ;FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Presidente: GARCIA VALDES DEYRIZAR ALFREDO. Con.Delegado: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Nombramientos. Consejero: GARCIA VALDES DEYRIZAR ALFREDO;MARTINEZ LOPEZ MANUEL;FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;ORTI OCHOA DE OCARIZJUAN;ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Presidente: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Con.Delegado: GARCIAVALDES DE YRIZAR ALFREDO. Datos registrales. T 28332 , F 207, S 8, H M 10859, I/A 60 ( 3.08.12).

23 de Julio de 2012
Revocaciones. Apoderado: BAS RUBIO AMPARO. Nombramientos. Apo.Manc.: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN;CASTUERAPEREZ JUAN FRANCISCO;LINARES PEREZ PILAR;SIERRA OLALLA BEGO脩A. Apoderado: INSERTE TORRES MONICA SARA.

12 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ VIVAS JOSEFA. Nombramientos. Apoderado: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZPAZ;RAMOS VALVERDE ANA MARIA. Datos registrales. T 11246 , F 206, S 8, H M 10859, I/A 58 (29.02.12).

14 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO. Presidente: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO.Con.Delegado: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN.Presidente: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Con.Delegado: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Datos registrales.T 11246 , F 206, S 8, H M 10859, I/A 57 ( 2.06.11).

14 de Abril de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ GONGORA EVA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SALIDO TOMASMANUEL. Apo.Manc.: MARTINEZ LOPEZ MANUEL;RODRIGUEZ SACRISTAN DIEGO. Datos registrales. T 11246 , F 205, S 8, H M10859, I/A 56 ( 4.04.11).

13 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONGORA EVA. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 55 el cese dedo帽a Eva Fernandez Gongora como Consejero. Datos registrales. T 11246 , F 205, S 8, H M 10859, I/A 55 (16.02.11).

28 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOZAL MARTIN JUAN. Vicepresid.: FERNANDEZ GONGORA EVA. Nombramientos. Consejero:FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL. Datos registrales. T 11246 , F 205, S 8, H M 10859, I/A 55 (16.02.11).

04 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ LOPEZ MANUEL;TORRES SOLER PATRICIA;ALONSO FERNANDEZ LUIS. Datosregistrales. T 11246 , F 204, S 8, H M 10859, I/A 54 (22.02.10).

05 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apoderado: MORENO BRITAPAJA ANTONIO. Datos registrales. T 11246 , F 204, S 8, H M 10859, I/A 53(26.01.10).

21 de Agosto de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: DUPUY DE LOME CHAVARRI LUIS. Datos registrales. T 11246 , F 204, S 8, H M 10859, I/A 52(31.07.09).

01 de Julio de 2009
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ FERRERO ROSARIO;JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO;DUPUY DE LOMECHAVARRI LUIS;GARCIA BUTRAGUE脩O ANGEL;MORO DOMINGUEZ LISARDO. Apo.Manc.: DUPUY DE LOME CHAVARRI LUIS.Apoderado: RAUNICH CLAUDIA ALEJANDRA;QUINTANAL PIGREE MARIE FRANCE;RAUNICH CLAUDIA ALEJANDRA;VIVASBENKER JUAN PABLO. Nombramientos. Apoderado: ALEU RODRIGUEZ JUAN ELIAS;VIDAURRE ACOSTA FRANCISCOJAVIER;TORRES SOLER PATRICIA Datos registrales. T 11246 , F 203, S 8, H M 10859, I/A 51 (19.06.09).

13 de Enero de 2009
Nombramientos. Consejero: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO. Presidente: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO.Con.Delegado: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO. Datos registrales. T 11246 , F 202, S 8, H M 10859, I/A 50 (26.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n