Actos BORME de Amex Asesores De Seguros Sociedad De Agencia De Seguros Vinculada Sa
15 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MORENO BRITAPAJA ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ PEREZ MARIA. Datosregistrales. T 43936 , F 142, S 8, H M 10859, I/A 102 ( 8.09.23).
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 28潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 43936 , F 143, S 8, H M10859, I/A 103 ( 8.09.23).
13 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: LINARES PEREZ PILAR. Datos registrales. T 43936 , F 142, S 8, H M 10859, I/A 101 ( 6.06.23).
23 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: LANDRIEU HELENE BRIGITTE CECILE;MU脩OZ BERZAL ALEJANDRO. Datos registrales. T 43936 ,F 141, S 8, H M 10859, I/A 100 (15.03.23).
21 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: OLMOS LOPEZ MIRNA. Datos registrales. T 43936 , F 141, S 8, H M 10859, I/A 99 (13.03.23).
16 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Secretario: BELZUZ LARRUY ENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ LABRADOR EMILIODANIEL. Datos registrales. T 43936 , F 140, S 8, H M 10859, I/A 98 ( 9.02.23).
15 de Febrero de 2023Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 20 y 21 de los estatutos, relativos a convocatoria, constituci贸n, deliberaci贸n yacuerdos del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 43936 , F 140, S 8, H M 10859, I/A 97 ( 8.02.23).
22 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Apo.Manc.: DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Apo.Sol.:DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Nombramientos. Apo.Sol.: LANDRIEU HELENE BRIGITTE CECILE;CERDEIRAESTIRADO JOSE MANUEL;GONZALEZ DELGADO NATALIA-ELIANA;BOVEDA MELERO ROSARIO. Datos registrales. T 28332 , F223, S 8, H M 10859, I/A 96 (15.11.22).
Otros conceptos: Ha cambiado el domicilio social del Socio Unico, la sociedad "AMERICAN EXPRESS DE ESPA脩A, S.A.", a laAvenida del Parten贸n, n煤mero 12-14, Campo de las Naciones, de 28042 Madrid. Datos registrales. T 704 , F 35, S 8, H M 10859, I/A13M (15.11.22).
13 de Abril de 2022Nombramientos. Coauditor: MAZARS AUDITORES SLP;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Auditor: MAZARSAUDITORES SLP. Datos registrales. T 28332 , F 223, S 8, H M 10859, I/A 95 ( 6.04.22).
06 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: HUBERT MATHILDE SOPHIE. Nombramientos. Apo.Sol.: BERTRAND ELSA OPHELIE;BARNESANDREW ROBERT. Otros conceptos: Se actualizan los datos personales del apoderado nombrado en la inscripci贸n 84陋 don JamesJohn Houghton, en cuanto a su domicilio y al n煤mero de su pasaporte, siendo el nuevo n煤mero 5553664. Datos registrales. T 28332 ,F 222, S 8, H M 10859, I/A 94 (30.03.22).
07 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Apoderado: DINESEN VILLACIEROS MARIAELENA;CERDEIRA ESTIRADO JOSE MANUEL;SIERRA OLALLA BEGO脩A. Datos registrales. T 28332 , F 222, S 8, H M 10859, I/A93 (30.09.20).
05 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 222, S 8, H M 10859, I/A92 (28.09.20).
23 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 221, S 8, H M 10859, I/A91 (16.10.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DEL PINO ANA. Datos registrales. T 28332 , F 221, S 8, H M 10859, I/A 90 (20.05.19).
29 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Man.Soli: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZPAZ. Apo.Sol.: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Nombramientos. Apoderado: BOVEDA MELERO ROSARIO;SIERRAOLALLA BEGO脩A. Datos registrales. T 28332 , F 220, S 8, H M 10859, I/A 89 (20.11.18).
24 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 219, S 8, H M 10859, I/A88 (17.10.18).
09 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Revocaciones. Apoderado: ANDRADAVANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ;ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ;ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ.Nombramientos. Consejero: SIERRA OLALLA BEGO脩A. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;ORTIOCHOA DE OCARIZ JUAN. Con.Delegado: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Presidente: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Datosregistrales. T 28332 , F 219, S 8, H M 10859, I/A 87 ( 2.08.18).
22 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: BOVEDA MELERO ROSARIO. Datos registrales. T 28332 , F 218, S 8, H M 10859, I/A 86 (15.06.18).
22 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: DINESEN VILLACIEROS MARIA ELENA. Datos registrales. T 28332 , F 218, S 8, H M 10859, I/A 85(15.02.18).
20 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: ALONSO FERNANDEZ LUIS. Apo.Sol.: ALONSO FERNANDEZ LUIS. Apoderado: MONTEROGUTIERREZ ADOLFO;MONTERO GUTIERREZ ADOLFO;DIXON SOPHIE-ANNE-DOMINIQUE;MONTERO GUTIERREZ ADOLFO.Nombramientos. Apo.Sol.: HOUGHTON JAMES JOHN. Apoderado: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Man.Soli:ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Sol.: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Datos registrales. T 28332 , F216, S 8, H M 10859, I/A 84 (12.12.17).
27 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 28332 , F 216, S 8, H M 10859, I/A 82 (16.11.17).
Cambio de domicilio social. AVDA DEL PARTENON 12-14 - CAMPO DE LAS NACIONES (MADRID). Datos registrales. T 28332 ,F 216, S 8, H M 10859, I/A 83 (20.11.17).
08 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 215, S 8, H M 10859, I/A81 (30.10.17).
22 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ RODRIGUEZ CRISTINA LETICIA;MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Datos registrales. T28332 , F 215, S 8, H M 10859, I/A 80 (14.09.17).
14 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ PATON JACINTO;ALEU RODRIGUEZ JUAN ELIAS;VIDAURRE ACOSTA FRANCISCOJAVIER. Apo.Manc.: RODRIGUEZ SACRISTAN DIEGO. Nombramientos. Apoderado: DIXON SOPHIE-ANNE-DOMINIQUE;HUBERT MATHILDE SOPHIE. Datos registrales. T 28332 , F 214, S 8, H M 10859, I/A 79 ( 6.06.17).
01 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Datos registrales. T 28332 , F 214, S 8, H M 10859, I/A 78(22.02.17).
11 de Octubre de 2016Revocaciones. Apoderado: SUAREZ DE LEZO Y CRUZ CONDE RAFAEL. Datos registrales. T 28332 , F 214, S 8, H M 10859, I/A77 (30.09.16).
26 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 214, S 8, H M 10859, I/A76 (16.08.16).
24 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBAS PABLO ALEJANDRO. Presidente: RIBAS PABLO ALEJANDRO. Revocaciones. Apoderado:RIBAS PABLO ALEJANDRO. Nombramientos. Presidente: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Con.Delegado: ORTI OCHOA DEOCARIZ JUAN. Datos registrales. T 28332 , F 213, S 8, H M 10859, I/A 75 (14.06.16).
21 de Junio de 2016Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 2陋 EL PODER OTORGADO A BNEDICTO ALFREDO, SIENDO LOCORRECTO BENEDICTO ALFREDO QUE FUE REVOCADO EN LA INSCRIPCION 4陋. Datos registrales. T 704 , F 29, S 8, H M10859, I/A 2 (25.03.91).
07 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MEYER PELLEGRINI EMILIO MARTIN. Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIAELENA;RODRIGUEZ SACRISTAN DIEGO FERNANDO;TORRES SOLER PATRICIA.Apo.Sol.: TORRES SOLER PATRICIA.Nombramientos. VsecrNoConsj: RAMAJO SANZ CLAUDIA. Datos registrales. T 28332 , F 213, S 8, H M 10859, I/A 74 (26.02.16).
26 de Agosto de 2015Nombramientos. Apoderado: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN;FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;RIBAS PABLOALEJANDRO;MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Datos registrales. T 28332 , F 212, S 8, H M 10859, I/A 73 (18.08.15).
19 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 212, S 8, H M 10859, I/A71 (10.08.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Presidente: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO.Con.Delegado: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Nombramientos. Consejero: ALONSO FERNANDEZ LUIS;RIBAS PABLOALEJANDRO. Presidente: RIBAS PABLO ALEJANDRO. Con.Delegado: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Datos registrales. T28332 , F 212, S 8, H M 10859, I/A 72 (10.08.15).
11 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: RAMOS VALVERDE ANA MARIA. Datos registrales. T 28332 , F 212, S 8, H M 10859, I/A 70 ( 3.03.15).
13 de Octubre de 2014Revocaciones. Apoderado: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Man.Soli: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZPAZ. Nombramientos. Consejero: MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Apoderado: MONTERO GUTIERREZ ADOLFO. Datos
10 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 210, S 8, H M 10859, I/A68 ( 2.10.14).
28 de Enero de 2014Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ MANUEL;MARTINEZ LOPEZ MANUEL;MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Apo.Manc.:MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Apo.Sol.: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Apo.Manc.: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales.T 28332 , F 210, S 8, H M 10859, I/A 67 (20.01.14).
05 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 210, S 8, H M 10859, I/A66 (29.07.13).
26 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: NOZAL MARTIN JUAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;ORTIOCHOA DE OCARIZ JUAN;ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Apo.Sol.: CHELTON PEREZ IRENE. Apo.Manc.:
02 de Abril de 2013Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 208, S 8, H M 10859,I/A 64 (19.03.13).
26 de Marzo de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28332 , F 208, S 8, H M 10859, I/A63 (19.03.13).
13 de Febrero de 2013Nombramientos. VsecrNoConsj: MEYER PELLEGRINI EMILIO MARTIN. Datos registrales. T 28332 , F 207, S 8, H M 10859, I/A 61( 5.02.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 28332 , F 207, S 8, H M 10859, I/A 62 ( 5.02.13).
17 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO;MARTINEZ LOPEZ MANUEL;ANDRADA VANDERWILDESANZ BRIZ PAZ;FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN. Presidente: GARCIA VALDES DEYRIZAR ALFREDO. Con.Delegado: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Nombramientos. Consejero: GARCIA VALDES DEYRIZAR ALFREDO;MARTINEZ LOPEZ MANUEL;FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL;ORTI OCHOA DE OCARIZJUAN;ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZ PAZ. Presidente: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Con.Delegado: GARCIAVALDES DE YRIZAR ALFREDO. Datos registrales. T 28332 , F 207, S 8, H M 10859, I/A 60 ( 3.08.12).
23 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: BAS RUBIO AMPARO. Nombramientos. Apo.Manc.: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN;CASTUERAPEREZ JUAN FRANCISCO;LINARES PEREZ PILAR;SIERRA OLALLA BEGO脩A. Apoderado: INSERTE TORRES MONICA SARA.
12 de Marzo de 2012Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ VIVAS JOSEFA. Nombramientos. Apoderado: ANDRADA VANDERWILDE SANZ BRIZPAZ;RAMOS VALVERDE ANA MARIA. Datos registrales. T 11246 , F 206, S 8, H M 10859, I/A 58 (29.02.12).
14 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO. Presidente: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO.Con.Delegado: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: ORTI OCHOA DE OCARIZ JUAN.Presidente: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Con.Delegado: GARCIA VALDES DE YRIZAR ALFREDO. Datos registrales.T 11246 , F 206, S 8, H M 10859, I/A 57 ( 2.06.11).
14 de Abril de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ GONGORA EVA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SALIDO TOMASMANUEL. Apo.Manc.: MARTINEZ LOPEZ MANUEL;RODRIGUEZ SACRISTAN DIEGO. Datos registrales. T 11246 , F 205, S 8, H M10859, I/A 56 ( 4.04.11).
13 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONGORA EVA. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 55 el cese dedo帽a Eva Fernandez Gongora como Consejero. Datos registrales. T 11246 , F 205, S 8, H M 10859, I/A 55 (16.02.11).
28 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: NOZAL MARTIN JUAN. Vicepresid.: FERNANDEZ GONGORA EVA. Nombramientos. Consejero:FERNANDEZ SALIDO TOMAS MANUEL. Datos registrales. T 11246 , F 205, S 8, H M 10859, I/A 55 (16.02.11).
04 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ LOPEZ MANUEL;TORRES SOLER PATRICIA;ALONSO FERNANDEZ LUIS. Datosregistrales. T 11246 , F 204, S 8, H M 10859, I/A 54 (22.02.10).
05 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: MORENO BRITAPAJA ANTONIO. Datos registrales. T 11246 , F 204, S 8, H M 10859, I/A 53(26.01.10).
21 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: DUPUY DE LOME CHAVARRI LUIS. Datos registrales. T 11246 , F 204, S 8, H M 10859, I/A 52(31.07.09).
01 de Julio de 2009Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ FERRERO ROSARIO;JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO;DUPUY DE LOMECHAVARRI LUIS;GARCIA BUTRAGUE脩O ANGEL;MORO DOMINGUEZ LISARDO. Apo.Manc.: DUPUY DE LOME CHAVARRI LUIS.Apoderado: RAUNICH CLAUDIA ALEJANDRA;QUINTANAL PIGREE MARIE FRANCE;RAUNICH CLAUDIA ALEJANDRA;VIVASBENKER JUAN PABLO. Nombramientos. Apoderado: ALEU RODRIGUEZ JUAN ELIAS;VIDAURRE ACOSTA FRANCISCOJAVIER;TORRES SOLER PATRICIA Datos registrales. T 11246 , F 203, S 8, H M 10859, I/A 51 (19.06.09).
13 de Enero de 2009Nombramientos. Consejero: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO. Presidente: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO.Con.Delegado: MARQUEZ GARCIA RAFAEL FRANCISCO. Datos registrales. T 11246 , F 202, S 8, H M 10859, I/A 50 (26.12.08).